the royal gazette royale - new brunswickthe royal gazette — november 26, 2003 1233 gazette royale...

28
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Postes Canada Accord sur la vente de produits n o 40065485 Canada Post Product Sales Agreement # 40065485 Vol. 161 Wednesday, November 26, 2003 / Le mercredi 26 novembre 2003 1231 ISSN 0703-8623 Notice to Readers Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the editor no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the editor. Please note changes in regular deadlines affecting the following publications: For more information, please contact the editor at 453-8372. Edition Revised Deadline December 24, 2003 Monday, December 15, 2003, 12 noon December 31, 2003 Wednesday, December 17, 2003, 12 noon January 7, 2004 Monday, December 29, 2003, 12 noon Important Notice Avis aux lecteurs Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à l’éditrice, à midi, au moins 7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec l’éditrice. Veuillez prendre note du changement de l’heure de tombée des éditions suivantes : Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’éditrice au 453-8372. Édition Nouvelle heure de tombée Le 24 décembre 2003 Le lundi 15 décembre 2003 à 12 h Le 31 décembre 2003 Le mercredi 17 décembre 2003 à 12 h Le 7 janvier 2004 Le lundi 29 décembre 2003 à 12 h Avis Important

Upload: others

Post on 07-Sep-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Postes CanadaAccord sur la vente de produits

no 40065485

Canada PostProduct Sales Agreement

# 40065485

Vol. 161 Wednesday, November 26, 2003 / Le mercredi 26 novembre 2003 1231

ISSN 0703-8623

Notice to Readers

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe editor no later than noon, at least 7 working days priorto Wednesday’s publication. However, when there is apublic holiday, please contact the editor.

Please note changes in regular deadlines affecting the followingpublications:

For more information, please contact the editor at 453-8372.

Edition Revised DeadlineDecember 24, 2003 Monday, December 15, 2003, 12 noon

December 31, 2003 Wednesday, December 17, 2003, 12 noon

January 7, 2004 Monday, December 29, 2003, 12 noon

Important Notice

Avis aux lecteurs

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à l’éditrice, àmidi, au moins 7 jours ouvrables avant le mercredi depublication. En cas de jour férié, veuillez communiqueravec l’éditrice.

Veuillez prendre note du changement de l’heure de tombée deséditions suivantes :

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avecl’éditrice au 453-8372.

Édition Nouvelle heure de tombéeLe 24 décembre 2003 Le lundi 15 décembre 2003 à 12 h

Le 31 décembre 2003 Le mercredi 17 décembre 2003 à 12 h

Le 7 janvier 2004 Le lundi 29 décembre 2003 à 12 h

Avis Important

Page 2: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1232 Gazette royale — 26 novembre 2003

009159 009159 N. B. LTD.010354 010354 N.B. LTEE020994 020994 N.B. LTD.021078 021078 N.B. INC.021765 021765 N.B. LTD.031058 031058 N.B. LTD.031059 031059 N.B. LTD.031225 031225 N. B. LTD.034644 034644 N.B. LTD.040717 040717 N.B. LTD.040828 040828 N.B. LTEE/LTD.501416 043017 N.B. LTD.043426 043426 N.-B. LTEE043454 043454 N.B. LTEE/LTD043514 043514 N.B. LTD.043531 043531 N.B. Inc.043577 043577 N.B. LTD.043598 043598 N.B. LTEE501435 045734 N.B. CORP.046183 046183 N. B. LTD.046261 046261 N. B. INC.046331 046331 N.-B. LTEE046381 046381 NB INC.048582 048582 N.B. LTD.048861 048861 N.B. LTD.048931 048931 N. B. LTD.048947 048947 N.B. LTD.048951 048951 N.B. LTD.511008 050847 N.B. INC.051010 051010 N.-B. INC.051160 051160 N.B. INC.051189 051189 N.B. LIMITED051191 051191 N.B. INC.053011 053011 N.-B. LTEE053080 053080 N.B. LTEE/LTD053082 053082 N.B. LTEE053133 053133 N.B. LTD.053251 053251 N.B. LTD.053253 053253 N.B. LTD.055682 055682 N.B. INC.055741 055741 N.B. LTD.055745 055745 N.B. INC.055753 055753 N.B. LTD.055774 055774 NB LTD.055777 055777 N.B. INC.055793 055793 N.B. LTD.055794 055794 N.B. LTD.055802 055802 N. B. LTD.055803 055803 N.B. LTD.055820 055820 N.B. LTD.055821 055821 N.B.INC.055837 055837 N.B. LTD.055845 055845 N. B. INC.055848 055848 N. B. INC.055865 055865 N.B. INC.055881 055881 N.B. INC.

055896 055896 N.B. LTD.055919 055919 N.B. LTD.055920 055920 N.B. INC.055922 055922 N.B. LTD.055925 055925 N.B. LTD.055930 055930 N.B. LTD.055960 055960 N.B. INC.055964 055964 N.B. LTD.055966 055966 N.B. INC.058089 058089 N.B. LTD.058910 058910 N.B. LTD.058925 058925 N.B. LTD.058964 058964 N.B. LTEE/LTD.059008 059008 N.B. INC.059029 059029 N.B. INC.059051 059051 N.B. INC.059060 059060 N.B. INC.059092 059092 N.B. INC.515865 2canucks.com INC.051068 4 & 6 SCRIBNER CRESCENT LTD.500198 500198 N.B. LTD.501271 501271 N.B. LTD.501272 501272 N.B. LTD.501302 501302 NB LTD.501304 501304 N.B. LTD.501310 501310 N.B. LTD.501324 501324 N. B. INC.501388 501388 N.B. LTD.501396 501396 N. B. INC.501406 501406 N.B. LTD.501433 501433 N.B. INC.501474 501474 N.B. INC.503405 503405 N.B. INC.503548 503548 NB LTD.503566 503566 N.B. LTD.503567 503567 N.B. INC.503577 503577 N.B. LTD.503584 503584 N.B. LTD.503585 503585 N.B. LTD.503613 503613 N.B. LTD503620 503620 N.B. LTD.503622 503622 N.B. LTD.503625 503625 N.B. LTD.503648 503648 N.B. LTD.503650 503650 N.B. INC.503654 503654 N.B. LTD.503677 503677 N.B. INC.503684 503684 N.B. LTEE503687 503687 N.B. LTD.503695 503695 N.B. LTEE/LTD.503797 503797 N. B. LTD.503798 503798 N. B. LTD.503810 503810 N.B. INC.505967 505967 N.B. INC.505992 505992 N.B LTD.506037 506037 N.B. LTD.

506074 506074 N.B. LTD.506078 506078 N.B. INC.506103 506103 N.B. LTD.506108 506108 N.B. INC.506132 506132 N.B. INC.506167 506167 N.B. LTD.508007 508007 N.B. LTD.508073 508073 N.B. LTD.508180 508180 N.B. Ltd.508195 508195 N.B. Inc.508226 508226 N.B. LTD.508237 508237 N.B. Ltd.508249 508249 N.B. Ltd.508270 508270 NB Inc.508271 508271 N.B. LTD.508296 508296 NB Inc508306 508306 N. B. INC.508307 508307 N. B. INC.508322 508322 N.B. Ltd.508340 508340 N.B. LTEE508367 508367 N.B. LTD.508373 508373 N.B. INC.509372 509372 N.B. INC.510693 510693 N.B. Ltd.510744 510744 N.B. LTD.510745 510745 N.B. Inc.510753 510753 NB INC510756 510756 N.B. INC510767 510767 N.B. LTD.510770 510770 N.B. Ltd.510773 510773 N.B. LTD.510775 510775 N.B. LTD.510786 510786 N.B. Ltd.510799 510799 N.B. Ltd.510821 510821 NB LTD.510833 510833 N.B. LTD.510838 510838 NB LTD.510839 510839 NB Ltd.510846 510846 N.B. Ltd.510853 510853 N.B. LTD.510855 510855 N.B. Inc.510856 510856 N.B. Ltd.510861 510861 N.B. Ltd.510879 510879 N.B. Inc.510891 510891 N.B. INC.510923 510923 NB LTD510926 510926 N.B. Ltd.510927 510927 N. B. INC.513183 513183 N.B. Inc.513256 513256 N.B. Ltée513295 513295 N.B. Ltd.513307 513307 N.B. CORP.513318 513318 (N.B.) LTD.513320 513320 N.B. Ltd.513321 513321 N.B. LTD.513341 513341 (N.B.) LTD.

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provin-ciales et d’annuler l’enregistrement des corporations extra-provinciales

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialesSachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivan-tes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporationsont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou docu-ments requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la pu-blication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourradissoudre lesdites corporations.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations andto cancel the registration of extra-provincial corporations

Notice of decision to dissolve provincial corporationsTake notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to dissolve the following corporations pursuant toparagraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publicationof this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the cor-porations.

Business Corporations Act

Page 3: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003

513374 513374 N.B. LTD.513385 513385 N.B. Ltd.513387 513387 N.B. LTD.513408 513408 New Brunswick Inc.513457 513457 N.B. LTD.513478 513478 NB Inc.513509 513509 N.B. LTEE/LTD.513510 513510 N.B. INC.513514 513514 N.B. LTD.513540 513540 N.-B. LIMITÉE515129 515129 NB Inc.515554 515554 N.B. Ltd.515621 515621 NB Inc.515635 515635 N.B. LTD.515670 515670 N.B. Inc.515699 515699 N.B. INC.515712 515712 N.B. Ltd.515754 515754 N.B. INC.515783 515783 N.B. Inc.515787 515787 N.B. INC.515824 515824 N.B. LTD.515825 515825 N.B. LTD.515855 515855 N.B. INC.515872 515872 N.B. Inc.055869 A-1 PORTABLE TOILETS INC.040905 A. J. FORSYTHE HOLDINGS LTD.000057 A.D.L. ENTERPRISES LTD.000182 ACADIA DEVELOPMENT LTD.036452 ACADIA REALTY LTD.503619 ACER GARDEN PRODUCTS INC.503583 ADL MARKETING INC.501338 ADRENALIN SPORTS INC.515771 Ag Enterprises Inc.506079 AIRCRAFTERS LTD.046360 AIRPORT MINI - STORAGE RENTAL

(1989) LTD.059059 ALBERT COUNTY MUFFLER LTD.512911 Alexis Nihon Ste-Catherine Inc.053254 ALGAR HOLDINGS LTD.513464 Allaire Canada M39, Inc.043385 ALLENCORP CO. LTD.501288 ALLIANCE ASSOCIATES

INCORPORATED510883 Alliance Financial Solutions Inc.508364 ALLWAYS FUNDRAISING INC.508183 Alpha Marketing Ltd.510847 Amdocs Canada Inc.048938 AMG HOLDINGS LTD.058887 AMICO CONSTRUCTION INC.059020 ANDRE DOUCET CORPORATION

PROFESSIONNELLE LTEE055977 ANGUS ENTERPRISES INC.506083 Antoine Arsenault Contracting Ltd.000607 ANTONY REALTY-DEVELOPMENT

LTD.000652 APPRAISERS & DESIGNERS

CONSTRUCTION LTD.510793 Arctic East Consulting Ltd055879 ARGUS LAND COMPANY LTD.051043 ARSENAULT MEAT MARKET LTD.009684 ARTHUR LAWTON INVESTMENTS

LTD.000773 ARTHURS EXPRESS LTD000881 ASSOCIATION DES SEINEURS DU

GOLF LTEE513602 ATELIER LANDRY INC.515726 ATL PLUMBING & GAS FITTING

INC.000964 ATLANTIC ASSOCIATES LTD.501314 ATLANTIC AUTOMOTIVE &

AGRICULTURAL AGENCY INC.501311 ATLANTIC BIOCHEMICAL

RESEARCH INC.038659 ATLANTIC CREATIONS (1986) LTD.511002 ATLANTIC DENTURE CLINIC INC.001012 ATLANTIC HAIR STYLING

ACADEMY LTD.510790 ATLANTIC MACK HOLDINGS INC.046258 ATLANTIC MACK SALES, INC.

001038 ATLANTIC MICROBIOLOGY LIMITED

001041 ATLANTIC MUSIC ACADEMY LTD.031280 ATLANTIC NUCLEAR SERVICES

LTD.503765 ATLANTIC THERMAL WRAP LTD.501296 ATLANTIC TURFGRASS SERVICES

(1988) LTD.501426 ATVenture Components Inc.508213 Au Deuxième (1998) Inc.059115 AUBE DRYWALL INC.503747 AUDARG LTD.051113 AUTO AND TRUCK SELLER

MAGAZINE LTD.001179 AUTO SERVICE REPAIR OF

MONCTON LTD.001217 AZTEC HOLDINGS LTD.501319 B & B REALTY GROUP INC.040680 B & G TIRE & AUTOMOTIVE LTD.001349 BABCOCK ENTERPRISES LTD.036439 BAIG BLVD. MOTORS INC.043462 BARNSTORMERS AVIATION LTD.503633 BASIC CARE LTD055996 BAY VALLEY LOGGING LTD.501498 BAYSHORE:\FOLK.NET INC.001626 BEACH FRONT POOLS LTD.051117 BENBETH MANAGEMENT LTD.515709 Berco Industries Ltd.034577 BERRY’S BEST RESTAURANTS

LTD.059167 BETTER FUTURE FORESTRY LTD.055901 BIG RIVER CONSULTANTS INC.506189 BIG TIMBER EXPRESS TRUCKING &

LOGGING LTD.053227 BISCAYNE HOLDINGS LTD.036371 BISHSPEAK INVESTMENTS LTD.506092 BMLG EQUIPMENT LTD.501391 BOB’S COOL AIR INC.503640 BODYGENICS INC.053224 BODYLINES HEALTH & FITNESS

CLUB INC.515887 Boistech Design Inc.506181 BOOMORANG CLEANING

PRODUCTS LTD.501305 BOSUN’S YARD LTD.503789 BOUCTOUCHE VIDEO STORE INC.034748 BOUTIQUE D’ENCADREMENTS

RENE LTEE/RENE FRAME SHOPPE LTD

515784 BOWMAN AUTO SALES LTD.510952 BOYLCO INVESTMENTS INC.031195 BRENNAN HOLDINGS LTD.002293 BREWER’S AUTO BODY LTD.510752 BRI-SEL PLUS INC.508298 BRIAN M. ALLISON INC.508210 BRICKSHITHOUSE CLOTHING INC508212 BROKEN SPOKE SALOON INC055842 BROWNS FLAT FINANCE LTD.503597 BRUNSWICK NUCLEAR INC.046462 BRUNSWICK WOOD DESIGN INC.508244 Bulawayo Holdings Inc.046373 BURGESS SOFTWARE LTD.002576 BURNHILL INDUSTRIES LTD.503736 BURNS AND ROE NEW

BRUNSWICK, INC.033022 C & S INVESTMENTS LTD.515802 C F C Trucking Ltd.501316 C P S MEAT PACKERS LTD.043414 C. & P. THEBEAU PRODUCTS LTD.055968 C. D. PICKARD & SONS LTD.048907 C. J. & P. MCLAUGHLIN

CORPORATION011475 C. J. MUNN EQUIPMENT LTD.002730 C. T. P. ENTERPRISES LTD.058954 C.B. EXCAVATING LTD.048853 C.F.M. ELECTRICAL CONTRACTOR

(1996) LTD.508211 C.U. FINNET INTERNATIONAL

CORPORATION

058904 C.V.M. BUILDERS LTD.059220 C.W. GRANT LTD.007605 C.W. GUTHRIE & SON LTD.508359 CABEL’S SANITATION LTD.056150 CABRICK HOLDINGS LTD.505999 CAMPBELL & MITTON

ENTERPRISES INC.515781 CAMPBELL’S ANTIQUE

FURNITURE RESTORATION & SALES LTD.

034672 CAMSYS LTD.508263 CAN-AM ATLANTIC LUMBER CO.

LTD.503615 CANADA INDUSTRIAL CASTINGS

LTD.058799 CANADA LEISURE CORPORATION002886 CANADA REAL ESTATE CO. LTD.507109 CANADIAN FREIGHTLINE

SERVICES LTD.503749 CAPITAL CITY DRIVING ACADEMY

LTD.051015 CAPITAL PROJECTS AND

ASSOCIATES LTD.503603 CAR TEXTILES SUPPLIERS INC.506180 CARING MANNER INC.507894 cartwheel - Freelance Web Page

Publishing Inc.508310 CEDAR CABINS AND MORE INC.508220 CELTIC CROSS PUB &

RESTAURANT INC.043325 CENTENNIAL OFFICE SUPPLY LTD.036394 CENTRA GAS NEW BRUNSWICK

INC.003277 CENTRAL PLUMBING & HEATING

(1978) LTD.505983 CENTRAL STONE COMPANY508338 Centre-Jardin Méthé Garden Center Ltée/

Ltd.515751 CERTIFIED PEST CONTROL LTD.058974 CHALEUR MICRO SERVICES INC.043326 CHAMPION HILTZ VENTURE

CAPITAL LTD.503663 CHARLES E. LEGER GENERAL

CONTRACTOR LTD.510824 CIJI COFFEE LTD.059021 CINE-PARC NEGUAC (1994) LTEE040693 CITY HALL CAFE LTD.511004 CLASSIC COACH LINES LTD.004041 COLUMBO REALTY LTD.506100 COMMUNITY NEWS INC.513404 Computer Generated Solutions Canada

Holdings Inc.503669 COOL GREEN RECYCLING LTD.506211 CORNECT CONSULTING INC.515789 Corporate Connections Inc.051150 CORPORATION J.R. 1 LTD.051151 CORPORATION PROFESSIONNELLE

PIERRETTE DAIGLE INC./PIERRETTE DAIGLE PROFESSIONAL CORPORATION

508140 COSATEK INC.053120 COUGHLAN REALTY (1992)

LIMITED021468 COUNTRY FARM LTD.503731 COUNTRY PALACE INC.513423 CRABBE MOUNTAIN

CONSTRUCTION LTD.004492 CRAWFORD’S FURNITURE &

APPLIANCES LTD.055880 CTL Co. Ltd.004582 CURTIS KITCHENS LTD.508209 CUTLER DAVIS INC.513579 CyberCanadaCare Inc.503716 D & J LAFORGE TRANSPORT INC.515926 D & S SANITATION LTD.508377 D. M. HARVEY CONSTRUCTION

LTD.513526 D. MacDONALD INDUSTRIES LTD.506000 D.J. LEASING LTD.

Page 4: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1234 Gazette royale — 26 novembre 2003

503699 D.W.F. ENTERPRISES INC.051013 D.Y.L. HOLDING INC.513376 Dare Publications Inc.503621 DAVE NOBLE WOOD PRODUCTS

LTD.510915 Dave’s Environmental Services Ltd.059056 DAVID & SONS AUTO SERVICES

LTD.059082 DEFIANCE OF NEW BRUNSWICK,

INC.050765 DEGRACE ET GODIN

CONSTRUCTION LTEE051092 DELTA RENT-A-CAR LTD.046274 DENIS DIOTTE USED CAR LTD508375 DENTAL SUMMER SEMINARS INC.501437 DEVINE SANITATION LTD.515911 DILKO HOLDINGS LTD.513439 DIVISION L.S. INC.515801 DOCTEUR RÉNALD WILSON

CORPORATION PROFESSIONNELLE INC.

055799 DOCTOR VACUUM LTD.040725 DOMAINE RIVIERA INC.510889 Dominion Hosiery Inc.051157 DONALD ACHESON

PROFESSIONAL CORPORATION506179 DOOLY’S ANTIGONISH INC.501363 DOUBLE R ENTERPRISE (1995) LTD.005187 DOUCET SUPERMARCHE LTEE. -

DOUCET SUPERMARKET LTD.031979 DOUGLAS S. ELLIOTT

PROFESSIONAL CORPORATION040816 DOUGLASTOWN CONVENIENCE

LTD.513500 DR GUY LEBLANC C.P. INC.515860 DR. CLAUDE BELISLE

CORPORATION PROFESSIONNELLE INC.

510870 DR. G. A. FALLOWS PROFESSIONAL CORP.

513552 Dr. Isabelle Savaria Corporation Professionnelle

501438 DR. PATRICK CLEMENTS PROFESSIONAL CORPORATION

508460 DR. SEAN J. KEYES PROFESSIONAL CORPORATION

508349 DR. SUHAS KALGHATGI PROFESSIONAL CORPORATION INC.

051075 DR. WILLIAM L. JOHNSON PROFESSIONAL CORPORATION

510897 Dre Line Lavoie Dufour Corporation Professionnelle Inc.

040927 DUGASFAB INC.043558 DUGUAY MASONRY LTD503665 DUNBAR INSURANCE LTD.048841 DYNASTY REALTY INC.055770 E & M COMMUNICATIONS LTD.508402 E M W VENTURES LTD.016015 E. TAYLOR STORES LTD.059337 EAGLE TRUST HOLDINGS INC.503806 EARTH TREK UNLIMITED INC.043097 EASBY HOLDINGS INC046446 EAST COAST ENVIRO TECH LTD040875 EAST COAST HOUSING (SUSSEX)

LTD.506005 EASTERN CEDAR PRODUCTS INC.059218 EASTWAY VENTURES LTD.513394 Eastwind Holdings Limited056107 EBENEZER HOLDINGS INC.005630 EDMUNDSTON FOODS LTD.503772 ELECTRONIC SOCIAL CONTACTS

LTD.510910 Ellis Industries Ltd.508303 Elm City Electric Ltd.059150 ENTREPRISE ORIENTALE LTEE506072 ENVIRO-MATICS INC.005917 EPICERIE G.M.L. LTEE046174 ERABLIERE LA COULEE DOUCE

LIMITEE005964 ESTEY & CO., LIMITED513326 EURO AUTOHAUS INC.046275 EVANS U-STORE-IT INC.050996 EVER-BRITE INSTALLATIONS

(1993) LTD.006001 EVERETT FARMS LTD.508441 EVERGREEN PARTNERS LIMITED510755 Excel Investments Limited040713 F. W. F. INVESTMENTS LTD.034642 F.T.C. INVESTMENTS LTD.515719 FABU MANAGEMENT CORP031160 FAIRWEATHER’S HOLDINGS

LIMITED043586 FARMER’S SERVICES & SUPPLY

LTD508200 FERME LABRIE & FILS INC.506032 FIRST NATIONS MANAGEMENT

DEVELOPMENT CORPORATION037639 FIRST PRINT PHOTO LIMITED059083 FOLKINS ESTATES INC.042704 FONDATION BELLAVANCE LTEE048281 FORBES DEER FARMS INC.503760 FORCE 1 AUTOMOTIVE INC.513527 FORMATION INDUSTRIELLE P.A.

(2000) INC.053226 FORMATION INDUSTRIELLE

PENINSULE ACADIENNE INC.058970 FORSGREN & ASSOCIATES INC.038446 FOURRURES B. J. LTEE/B.J. FURS

LTD.506042 FOYER BEAULIEU INC.006484 FRANJI AGENCY LTD.053180 FRANK WILLISTON

CONSTRUCTION (1992) LTD.005002 FRED R. DICKINSON LTD.510924 FREELAND CONSULTING INC.055834 FRENETTE AMUSEMENTS (1992)

LTD.501326 FRESHELLE INC.043421 FROM THE TREE TO YOU LTD.508242 Frostbyte Computer Systems Inc.501477 FUNDY GLASS LTD.515889 FUNDY HOUSE RESTAURANT LTD.503576 FUNDY PRODUCTION ASSOCIATES

LTD.506204 FUTURE INTERNATIONAL

MANAGEMENT INC.503673 FUTURE VIDEO RENTAL (1996) INC.059052 G & L LOCATION D’EQUIPEMENT

LOURD LTEE-G & L HEAVY EQUIPMENT RENTAL LTD.

513405 G & S Fitness Inc.031234 G. & J. NADEAU HOLDING LTD.010750 G. A. MATTHEWS AND

ASSOCIATES LTD.501475 G. C. ADVANCED COMPUTING

SOLUTIONS LTD.055787 G. M. & H. HOLDINGS INC.503634 G. MCGRAW LTD.513473 G.L. MACHINE SHOP INC.513351 G.R.T. WISTED INSURANCE

ASSOCIATES INCORPORATED501460 G.R.W. VENTURES LIMITED513470 G.S. SERVICES ADMINISTRATIFS

INC.056104 GARAGE GILLES A. NADEAU INC.036369 GARDERIE EDMUNDSTON DAY

CARE CENTER INC.006943 GARFIELD TRUST LIMITED007857 GARY H. HATFIELD LTD.513398 GATOR’S PUB INC.053134 GAUDET R.M.C. LTEE510763 GEIKIE CONSULTING INC.503703 GEMS STORAGE LTD.515706 Geneau Consulting & Counselling Inc.048695 GENERAL E TRADING INC.513582 GENERAL P. HOLDINGS INC.011605 GEO. MCCOY & SONS LTD.

506040 GESTION 3034 HOLDINGS LTD.513364 GESTION AMUSEMENT HOLDINGS

INC.513446 GESTION PIERRE INC.055773 GESTION R.J. RINGUETTE INC.506123 GILLES MICHAUD C.A.

CORPORATION PROFESSIONNELLE INC.

053240 GOLDEN TORCH ELECTRIC LTD.505997 GOLO CONSTRUCTION LTD.048784 GOODFELLOW ENTERPRISES LTD.007380 GRAND FALLS INDUSTRIES,

LIMITED501399 GRAND ISLE SEAFOODS LTD.506091 GRAND LAKE INDUSTRIES INC.503674 GRAY’S AQUA COMPANY LTD.007500 GREEN’S AUTO PARTS LTD.007520 GREGAN ELECTRIC LTD.007547 GROOM INSURANCE LTD.503636 GROUPE LANTEIGNE LTEE033016 GUERETTE SPORTS INC.000350 H. G. AITON LTD.048954 H.A. HAMBROOK & ASSOCIATES

LTD.056165 H.M.K. HOLDINGS LTD.055999 HACHÉ DEVELOPMENTS INC. -

DÉVELOPPEMENTS HACHÉ INC.515744 Haemonetics Canada Ltd.007688 HAINES HOLDINGS LTD.508415 HAPTS INC.503623 HARBOURVIEW BLOOD CLINIC

INC059166 HARJO HOLDINGS INC.510875 Harper Trucking Ltd.031117 HARRISON BLACK LTD.503670 HAVA PACK INC.053095 HAYMARKET TRUCK & TRAILER

LTD.506003 HEALTH CARE PLANNING

ASSOCIATES INC.503555 HERITAGE CONVENIENCE STORE

LTD040744 HERITAGE HOUSE FOODS LTD.034684 HERITAGE INVESTMENTS INC.048805 HERITAGE SUR MER BY THE SEA

LTD.055963 High Performance Consulting Limited054896 HIGHTIDE HOLDINGS INC.055832 HIGHWAY COUNTRY CLUB INC.008079 HO JO HOTELS LIMITED503691 HOLLAND PARK LTD.008160 HOPPER BROS. LTD.038521 HOTEL SAINT JOHN LIMITED508330 HUDON INVESTMENTS LTD.501493 HUGE GLORY CANADA LTD.008312 HUTTGES GENERAL MERCHANTS

LTD.510780 Hydrant - Tec Inc.059025 HYDRAULICS UNLIMITED INC.055965 IC Management Inc.503637 IMPACT AQUACULTURE INC.515883 INDIAN LAKE LOGGING LTD.513330 INDUSTRIAL COMMERCIAL

CONTROLS SERVICES INC.506075 INFORMATIKA INC.046286 INGENIOUS IDEAS INC.048869 INNOVATIVE SOFTWARE FOR

BUSINESS LTD.503775 INTEGRI (2000) INC.004994 INTERMESOLI HOLDINGS LTD.053213 INVESTISSEMENTS IRENE

ARSENAULT LTEE055805 IRENA KAMINSKA M.D.

PROFESSIONAL CORPORATION503631 IRISHTOWN AUTO CLINIC INC.014982 ISAAC L. SELICK BROKERAGE LTD.051149 ISLAND VIEW AUTO BODY LTD.050995 IXOYE AQUACULTURE, INC.515910 J A PICKETT & ASSOCIATES INC.

Page 5: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1235 Gazette royale — 26 novembre 2003

038510 J. A. C. FISHING SUPPLIES LTD.031157 J. B. BOONE LTD.051202 J. B. LEASING LTD.059038 J. D. CORMIER TRANSPORT INC.048812 J. GODFREY ENTERPRISES LTD.505962 J. M. DENIS LAVOIE C.P. INC.053182 J. P. LANTEIGNE (1976) LTEE513428 J. R. Palmer’s Trucking Ltd.503651 J. SAULNIER TRUCKING LTD.055819 J. T. KNIGHT EXPORT SERVICES

INC.515810 J.D.R. SPORT LIMITEE503781 J.E. GODFREY LTD.008617 J.E.G. HOLDINGS LTD.048864 J.F.L. ARBITRATION SERVICES INC.046227 J.L. ROSS GENERAL CONTRACTING

LTD.503689 J.P. SMALL MOTOR REPAIR LTD.510765 J.W.M. INVESTMENTS LTD.053236 JAMES ANDREW INVESTMENT

CORP.501499 JARAC INC.055929 JARDINE HOLDINGS INC.506170 JASON’S PARADOR CAFE INC.055900 JAYMAR INDUSTRIES LTD.513336 JC PROFESSIONAL SERVICES LTD.506052 JCRJ INDUSTRIES INC.503580 JEAN-FRANCOIS LEROUX C.P. INC.506205 JEM TRAINING AND CONSULTING

LTD.053122 JENNAN ENTERPRISES LTD.038520 JOCAR INVESTMENTS LTD.011993 JOEY J. NEILL HOLDINGS LTD.011633 JOHN H. MACDONALD & SON

CONSTRUCTION LTD.508280 John Harding Insurance Ltd.031137 JOHN LITTLE HOLDINGS LTD.048818 JOHN’S SHOE STORE LTD.036442 JOLYN INC.046431 JUSMON HOLDINGS LTD.031138 JUST INVESTMENTS LTD.038506 K M CONTRACTORS LTD.510976 K. JENSEN SHIPPING LTD.051058 K. L. HOLDINGS LTD.508225 K. O. MEDIA INC.048011 K. V. FOUNDATION REPAIR INC.059027 KATHREN INC.508293 KAYLA TRANSPORT LTD.515735 KENNEBECASIS ISLAND ESTATES

LTD.009124 KENT DRY-WALL LTD.513433 KENT-VIC FOODS INC.513580 Kevin’s Crane Rentals Inc.038505 KEY MECHANICAL LTD.043570 KEYSTONE REALTY (1988) LTD.513335 KIDD KUTS LTD.510935 KIERS COMMUNICATIONS GROUP

2000 INC.510802 KINGSCLEAR ABORIGINAL

CONVENIENCE CENTRE LTD.510803 KINGSCLEAR FISHERIES LTD.510801 KINGSCLEAR HOLDING

CORPORATION038534 KINNEY’S SERVICE CENTRE LTD.511013 KNOCKWOOD LOGGING INC.009400 L & I DRUG CO. LTD.046263 L. GAUDET’S CONVENIENCE

STORE LTD.501339 L.M. LARONDE ENTERPRISE LTD.510893 LA MAISON TOURISTIQUE DUGAS

INC.506197 LAKESHORE FUELS INC.051091 LANDAL INC.508274 LARC BUILDING SYSTEMS INC.513532 Lasting Image Landscaping Ltd.033051 LAW INVESTMENTS LIMITED506122 LAWN MANAGEMENT INC.034728 LAWSONS 194 KILLAM DRIVE INC.510831 LE CLUB JUKAI-RYU JU-JUTSU

LTÉE510887 LE MANOIR DES LACS INC.014744 LE SALON DU PECHEUR LTEE508454 LEADERS REAL ESTATE SERVICES

LTD.055853 LECLAIR TRANSMISSIONS LTEE/

LTD.034765 LEGER’S FASHIONS INC.513349 LEGER-HALE HOLDINGS LTD.510872 Lencorp Corporation036428 LES ENTREPRISES I.V. LTEE055989 LES ENTREPRISES L R M INC.506073 LES ENTREPRISES PALLOT & FILS

LTEE043360 LES ENTREPRISES ROVIC LTEE043416 LES GESTIONS FTL HOLDINGS

LTEE/LTD.501317 LES INVESTISSEMENTS B. MORIN

LTEE040902 LES INVESTISSEMENTS EMY LTEE008531 LES INVESTISSEMENTS LOSIER &

LEBLANC LIMITEE058851 LES INVESTISSEMENTS MAISON

CELEBRITE HOMES LTEE513561 LES PEINTURES G.P. INC.048851 LES SUCRERIES THERIAULT LTEE506149 LES TITANS JUNIORS “A” DE LA

PENINSULE ACADIENNE INC. - THE JUNIOR “A” TITANS OF THE ACADIAN PENINSULA INC.

036456 LINJA CONSUMERS CANADA LTD.046267 LITTLE FORKS LTD.510921 LITTLE RIVER SOFTWARE INC.009986 LOCAL 502/213 HOLDINGS LTD.503600 LOONIE TOONIE TREASURES INC.053179 LORNFRANK PROPERTIES LTD.056136 LRW ENTERPRISES INC.010122 LUTES ELECTRIC LTD.036367 LYNMAN DEVELOPERS LTD.513449 M & H Heating Ltd.032964 M & J AUTO SALES LTD.046277 M W HOLDINGS INC.515902 M&N PanEnergy Ltd.010848 M. J. MELENCHUK LTD.510885 M.G. BÉLANGER ENTREPRISE INC.503605 M.T.A. MURRAY INC.003159 MAC CARTER LTD.011624 MACDONALD ENTERPRISES LTD.055772 MACDONALD-BOYCE

INCORPORATED043561 MACTAQUAC HOLDINGS LTD.507752 MAGIC NAILS LTD.515767 Maillet Family Trust Holdings Ltd.048838 MANN’S GARDEN CENTRE &

LANDSCAPING LTD.506183 MAPLE LEAF CONVENIENCE LTD.010424 MAPLES CANTEEN (1976) LTD.059089 MARCHE GB INC.059032 MARITIME CROP CARE INC.506009 MARITIME HOME INSPECTORS

INC.058953 MARITIME WOOD BROKERS INC.048856 MARK CALDER BUILDING &

FOUNDATION CONSTRUCTION CO. LTD.

503680 MARTIN’S LAUNDRY LTD.513396 MATTHEW BRADY INTERIOR &

ANTIQUES LTD.506059 MAVRICK TRANSPORTS INC.051137 MAYFIELD GREENHOUSES LTD.011545 MCADAM OPTICAL DISPENSARY

LIMITED055860 McCALLUM HOLDINGS LTD.510844 McDonald-Miller Inc.501476 MCNIC MUSIC LTD.510751 MDL Consultants Inc.515814 MECHFO ENTERPRISES INC.056168 MEGA INVESTMENTS LTD.501341 MELANSONS MAT RENTAL LTD.

508182 MENUISERIE ACADIPRO INC.038046 MENUISERIE LIONEL CORMIER

LTEE510742 MERCEDES CONSTRUCTION LTD.055874 MIDORO INC.513483 MILESTONE VENTURES LTD.508232 MILLFINDER PUBLICATIONS INC.508333 MIRAMICHI DRYWALL &

PAINTING LTD.055923 MIRAMICHI HOLDINGS LTD.011076 MIRAMICHI MANORS LIMITED031087 MISHO COLOR LAB LTD.048910 MONCTON CHRYSLER DODGE

(1990) LTD.033046 MONCTON MARKET ENTERPRISES

INC.011296 MONCTON ORTHODONTICS LTD.011375 MORRIS MUSIC LTD.011377 MORRIS WHOLESALE LTD.053257 MURCH’S HOME IMPROVEMENTS

(1992) LTD.511015 MYRIA ENTERPRISES INC.000170 N. ABUD & SONS LTD.506117 N. SAVOIE & FILS LTEE048916 N.B.P. ENTERPRISES INC.501415 N.I. AGRICULTURE & FORESTRY

INC.501295 N.P. CONTRACTING LTD.053156 NAPKE ENTREPRISE LTEE506142 NET NUT INC.012027 NETTOYEURS CARAQUET

CLEANERS LTD. - NETTOYEURS CARAQUET CLEANERS LTEE.

506087 NEW BEGINNINGS SENIORS DAY PROGRAM LTD.

515773 New Dimension Solutions Canada, Inc.031078 NEW MARYLAND GROCERIES LTD.501270 NEW VIEW REALTY LTD.012182 NEWCASTLE RINK ASSOCIATION,

LIMITED510979 NICHOLSON COY HOME INC.031290 NICJO HOLDINGS LTD.501473 NIXX CORP.501429 NORM’S COLLISION CENTRE LTD.007282 NORMAN GOODINE TRUCKING

LTD.059224 NORSCORE INC.510871 North American T.V. & Satellite Ltd.501350 NORTHEAST OUTFITTERS INC.040916 NUMIDIA LTD.508287 Nutri-Logic Inc.508425 Ocean Transportation Services Freight

Forwarding Inc.513379 OERA INC513448 Offshore Solutions Inc.501331 ONONDAGA HOLDINGS CORP.515913 OPÉRATIONS FORESTIÈRES T.M.

INC.501502 OPTIMA CONSULTANTS LTD.506046 ORANGE MEDICAL TECHNOLOGY

INC.508341 Ortholab Inc.050969 OUTER SPACE SALES LTD.515725 OUTSTANDING SOFTWARE INC.503596 P & G PROJECTS LTD.006650 P. D. FULLARTON MANAGEMENT

SERVICES LTD.046220 P. J. RUSSELL INC.513541 P.B. ENTERPRISES LTD.032966 PABANCO LTD.055895 PARADIGM TECHNOLOGY INC.038603 PARK AVENUE INVESTMENTS LTD.012812 PARK HOUSE INN LTD.013083 PARKWAY DEVELOPMENTS LTD.032985 PARRTOWN PLACE LTD.010890 PAUL F. MERZETTI LTD.043551 PAUL LEMAY TRANSPORT LTEE506186 PAUL MCCOY CONTRACTING LTD.055942 PAUL W. KENNEDY PROFESSIONAL

Page 6: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1236 Gazette royale — 26 novembre 2003

CORPORATION012877 PAUL’S CERAMIC TILE LTD.501450 PECHERIES ALDRICE SAVOIE INC501446 PECHERIES DOMITIEN DUGUAY

INC508231 PEEL INVESTIGATIONS &

SECURITY SERVICE INC.043508 PELTOMA FOREST PRODUCTS LTD.508224 Pembroke Marketing Ltd.040750 PENMEL INC.051188 PENNIAC CONSTRUCTION AND

MANAGEMENT LTD.055957 PEPPERTREE HOLDINGS LTD.503618 PERFECT KITCHEN DESIGN INC.040926 PERFECTION DAIRY FOODS

LIMITED058808 PERRY’S MARKET LTD.031209 PHASE ELECTRIC HOLDINGS LTD.510911 PHOENIX MILLS INVESTMENTS

INC.034730 PHOTO KING LTD.048885 PHYSIOTHERAPIE BAIE DES

CHALEURS PHYSIOTHERAPY INC.

043589 PICARD SERVICE INC.046367 PILOTES DU FUTUR INC.515903 PLACEMENT PARASOL (2001) LTÉE513441 Platinum Transport Ltd.515733 PLM (2001) HOLDINGS LTD013210 POEM HOLDINGS LTD.508329 PORT CITY ROOFING (1998) LTD.506070 PREMIER REALTIES INC./LES

IMMEUBLES PREMIER INC.055742 PRIMA GRAPHIC INC.046204 PRO NATURA INC.503635 PRO-RITE RENOVATORS LTD.508206 Productions J’Arts Rive Inc.510980 Professional Power Products Inc.059141 PROGRESSIVE LEARNING CENTRE

INC.515703 Proligo Canada Inc.016702 PROPERTY SPECIALISTS LTD.508400 PROSENSYS INC.031276 PROSPECT CONTRACTORS LTD.058946 PROVINENT CORP.503753 PUBLICAN NETWORKS

INTERNATIONAL INC.034742 PVH CONSTRUCTORS INC.513572 Quik Lube Centre Inc.048870 QUINCAILLERIE GAUTHIER

HARDWARE LTEE503776 QUINN COMMERCIAL REALTY LTD013547 QUODDY HOLDINGS LTD.501328 R & R FOREST PRODUCTS LTD.510787 R. & M. PRINTING AND

PUBLISHING LTD.503793 R. AND R. GAME FARM LTD.513347 R. C. PAWN SHOP LTD.503704 R. FOLKINS HOLDINGS LTD.038522 R. J. G. ENTERPRISES LTD.005340 R. L. DUPLISEA & CO. LIMITED508334 R. MATCHETTS PLUMBING,

HEATING, ELECTRICAL, PARTS & SERVICES LTD.

506039 R.A.R.C. INVESTMENTS LTD.510984 R.S. THORNE TRANSPORT LTD.059153 R.W. BURPEE CARPENTRY &

CONTRACTING LTD.513327 Radio Diffusion Acadie Inc.048857 RAIL ENTERPRISES LIMITED513616 RainMaker Contact Centres Inc.513485 RALPH’S REPAIR SERVICE INC.059142 RAY’S IMPORT EXPORT LTD./LTEE053046 RDB ENTERPRISES LTD.501325 RDS TECHNOLOGIES INC.048131 REAL ESTATE 2000 LTD510857 Red Lion Group Inc505985 REG PLUMBING & HEATING LTD.046271 REGISTERED REALTY LTD.013812 REID’S PHOTO CENTRE LTD.

048847 REPUBLIC BODY SHOP INC.511011 RHYTHMS CANADA INC.043563 RICHARD J. GALLANT

CONSULTANT INC.501405 RICHARD LODGE PROFESSIONAL

CORPORATION503624 RICHARD MAZEROLLE HEATING

LTD.014005 RICHIBUCTO DENTURIST LTD. -

PROTHESISTE DENTAIRE RICHIBUCTOU LTEE.

508388 RICHIBUCTO RIVER ADVENTURES INC.

513551 Richie Foods Inc.510936 RidgeCon Inc.059118 RIL ENTERPRISES LTD.014047 RIO HOTEL LIMITED040846 RIPPLE ENTERPRISES LTD.510902 Riverfront Recreation Inc.510983 Riverview Tax & Accounting Ltd.510985 RIVERVIEW TAX CENTRE LTD.508337 RIX PUB INC.503668 ROAN MARKETING ASSOCIATES

LTD.515819 Robert’s Renovations Inc.031097 ROBKEI LTD.051039 ROD STEARS FREELANCE

PHOTOGRAPHER LTD.051127 RODEB INVESTMENTS

CORPORATION503641 ROGER COLLETTE TRUCKING LTD.513039 ROR INDUSTRIES INC.513458 ROUE DU CAPITAINE INC. -

CAPTAIN WHEEL INC.506198 ROULEMENTS ET SERVICES

PENINSULE LTEE508406 RT MEDIAWORX INC515722 Ruscana Intertrade Inc.059176 RY SHAW HOLDINGS INC.032980 RYER’S HOLDINGS LTD.059113 S & P FORESTRY INC.014482 S. & S. LIMITED001728 S. W. BELL, LIMITED038533 S.A. THERIO INC.508268 S.O.S. CENTER FOR STARTING

OVER SAFE INC.048955 S.R.V. HOLDINGS LTD.510977 SAINT JOHN SAND & GRAVEL

COMPANY LIMITED032962 SALON DE COIFFURE PROFILE

LTEE/LTD.510762 SAMPSON-SORBARA WRITERS INC.058881 SCHOFIELD MECHANICAL

CORPORATION038594 SCOTIA FABRICS INC.503614 SCRIBNER CONSTRUCTION &

RENOVATION INC.038577 SEAFARER’S MARINE &

INDUSTRIAL LTD.508304 SEASWELL INC.053206 SELECT FOREST PRODUCTS LTD.056171 SENIOR WATCH INC.014994 SENO LIMITEE506112 SENTINEL CONSULTING LTD.503735 SERGEO FOODS INC.513367 SERPENTINE LODGE LTD.513471 SERVICE PRO OVERHEAD DOOR

LTD.043440 SHARAF ENERGY SYSTEMS

INCORPORATED021470 SHEDIAC MIDTOWN SERVICE

STATION LTD.056219 SHEDIAC WATER CONDITIONING

LTD.032986 SHEMOGUE POULTRY PRODUCERS

LTD.510930 SHETLAND CONTRACTING LTD.053130 SHORT TRACK CORNER LTD.503758 SIERRA COMMERCIAL CLEANING

LTD.

046438 SIGMA HOLDINGS LTD.015194 SILVERWOOD PROJECTS LTD.503692 SLB COMMUNICATION INC.508353 Sogesco Corporation506069 SOUTH SIDE GRABBA TABACCA

INC.038370 SPILMAN BUILDERS LTD.040899 SPRINGWATER CAMPGROUNDS

LTD.040901 SPRINGWATER RESTAURANT LTD.513306 SRG PERLITE LTÉE036446 ST. ANTOINE CONSTRUCTION &

SIDING LTD.014563 ST. CROIX PULPWOOD, LIMITED045970 STAFFORD’S INVESTMENTS LTD.503756 STAR INDUSTRIES (1997) LIMITED510898 Star-Scape Communications Inc.059044 STEELBILT BUILDING SYSTEMS

INC.506007 STEF DISTRIBUTION INC.033071 STONEPOST VENTURES LTD.508239 STRATEGIC INSIGHT

INTERNATIONAL INC.506187 SUCASA REALTY INC.048913 SUGARLOAF INVESTMENTS (1990)

INC.513381 Summit Real Estate Inc.015738 SUN-BEAU ENTERPRISES LTD.501299 SUNCORP EQUITIES INC.059030 SUNSHINE REFRIGERATION &

AIRCONDITIONING LTD.015804 SUPERIOR PRECAST CONCRETE

PRODUCTS LTD.513487 SURFACE AIR DIVING

CORPORATION055987 SUSSEX FABRICATORS LTD.015882 SWANS FURNITURE STORE LTD.033019 SYMCO PROPERTIES LTD.053168 T & R SPORTS (BATHURST) LTD.055921 T.H.E. COSTELLO COMPANY INC.503745 T.J.K. HOLDINGS INC.508410 TAN MASTER INC.501362 TANG’S HOLDING LTD.510841 Tantramar Driving School Ltd.506045 TAPUZ MEDICAL TECHNOLOGY

NA INC.508362 TAYLOR LAKE LODGE INC.040449 TECH-SHOE LTD.508267 Teleride Inc.506012 TERI-PORC INC.016083 TERRY’S ELECTRICAL LTD.034723 TFE INDUSTRIES INC.048541 THE A TEAM STEAMERS LTD.048963 THE BISHOP’S VIEW INC.056123 THE BROOKVILLE GROUP INC.506029 THE CUT CORPORATION059112 THE DUKE OF ALLISON PUB &

CAFE LTD.043197 THE ICE BUCKET INC.513325 The International Loan Consultants Ltd.510738 The Ivory Owl Learning Company, Ltd.513406 THE KETCHUM GROUP LTD.501411 THE LIBRARY RESTAURANT AND

LOUNGE INC.020998 THE LITTLE STUDIO LTD.503607 THE OUTLET QUIK STOP INC.506093 THE PANEL SHOP INC.513562 The Pit Stop Bar Inc.016129 THOMAS CONSTRUCTION LIMITED031096 THOMPSON & SON INC.051179 TIMBERLAND DISTRIBUTORS LTD.508197 TIMTEK INC.038479 TOBIAS HOLDINGS (1982) LTD.515739 Tobique Valley Outfitters Ltd.014373 TOM ROY INSURANCE LTD.501430 TONER TIME COMPUTER

PRODUCTS INC.510982 TOPCOAT SOLUTIONS INC.506084 TOTAL INSURANCE SERVICES LTD.515792 Toulouse Management Ltd.

Page 7: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1237 Gazette royale — 26 novembre 2003

058969 TOUR MONDE-ACADIE LTEE501382 TOURIM ACADIE INC.510941 TRADES EXTRA LTD.503727 TRANS-EASTERN INTERNATIONAL

INC.016324 TRANS-MAT LTEE056132 TRANSPORT INSTRUMENTATION &

CONTROLS LIMITED016340 TRAVEL ALL LTD.511014 TREVOR’S VAULT INC.059009 TRU-JON ENTERPRISES INC.510999 Trueline Construction Ltd.503773 TRY-US INSULATION LTD508405 TUMACO INC.503740 TWENTY-FIRST CENTURY VIDEOS

& CONV. INC.016493 TWO STREAMS FARMS LTD.011900 ULDERIC NADEAU, LIMITEE515870 UMS Therapy Services Inc.051162 UNCLE BOB’S CONVENIENCE

STORE LTD.503734 UNCLE ED’S SEA FOOD LTD/LES

FRUITS DE MER DE L’ONCLE EDDY LTEE

059047 UNIVERSAL BUILDERS LTD.510757 UPPER VILLAGE MALL

RESTAURANT LTD.503601 V-NETWORKS, INC.

036444 V.L.G. Electric Ltd.016668 VALLEY RENOVATIONS LTD.511016 VANDELAY HOLDINGS INC.503653 VET-ON-CALL INC.043378 VIDEO KLIP INC.508346 VIDIATC CONSULTING LIMITED043359 VILLA HUGUETTE MICHAUD INC.505971 VISION PLUS SOLARIUM/

SOLARIUM’S SALES & INSTALLATION INC.

506006 VISION PUBLISHING GROUP LTD.508286 VITA-NATUR INC.048850 VTS TRANSPORTATION LTD.016852 W. A. C. EXCAVATORS LIMITED048559 W. J. WILSON AND ASSOCIATES

LTD.508228 W.N. Covert Professional Corporation059128 WACKY WHEATLEY’S MATTRESS

DISCOUNTERS INC.055678 WADE DAVIS LOGGING INC.010124 WALTER J. LUTES LTD.053142 WASHINGTON ELECTRIC LTD.508325 WATER WORLD SCUBA CENTRE

INC.031115 WATERS EDGE ENTERPRISES LTD.058991 WAYNE MACBETH CONTRACTING

LTD.033053 WESTCAN HOLDINGS LTD.

503606 WHAT’S GOING ON - NEW BRUNSWICK INC.

033077 WHITE’S PHARMACY (1983) LTD.510954 WHOOPER TRANSPORT LTD.031216 WILLIAM EDGAR KENNY

HOLDINGS LTD.515851 WILLIAM J. MATTHEWS P.C.506055 WIND RIVER BOARDING KENNELS

LTD.020951 WINDSOR HOLDINGS LTD.506144 WOMEN BUSINESS CONNECTIONS

INC.036407 WOODHAVEN HOLDINGS LTD.506156 WOODSIDE FOUGERE SPORTS

MARKETING LTD.506096 WORTHY TRANSPORT LTD503589 WREATH VENTURES LTD.021367 WYNBERG LANDSCAPING LTD.506019 YDL INTERNATIONAL TRADING

INC.021390 YELLOWORK LTD. LTEE510746 YGGDRASIL FOREST PRODUCTS

LTD.038481 YORK SATELLITE T.V. LTD.021421 YOUNG & BUTTIMER LTD.056125 YVES MORNEAULT

DENTUROLOGISTE INC.

071231 157864 CANADA INC.071864 2357402 MANITOBA LTD.075638 3304264 CANADA INC.070712 682995 ONTARIO LIMITED077974 782399 Ontario Ltd.075627 AEROFIL INC.077987 Ajilon Communications Inc.074808 ALCELL FOREST PRODUCTS INC. -

LES PRODUITS FORESTIERS ALCELL INC.

018806 ALPHONSE LEPAGE INC.019973 ASSOCIATED FREEZERS OF

CANADA INC.076135 BAKER HUGHES CANADA INC.077490 BASF Canada Holdings Inc.019821 BEELINE FORWARDING LIMITED076977 BERKSHIRE INSURANCE SERVICES

INC.018809 BOUTIQUE DE REPARATION

GRONDIN LTEE - GRONDIN REPAIR SHOP LTD.

073010 BRUCE R. SMITH LIMITED073556 BURNAC CORPORATION077000 C.O. Bisson et Associés Inc.076531 CASTOR DISPATCH SERVICES LTD.072432 CHAPMAN & ASSOCIATES

WARRANTY RISK SPECIALISTS INC.

074029 CHERRYDALE FARMS CANADA, INC.

017249 CLA DISTRIBUTOR ASSISTANCE CORPORATION

075185 CONSTRUCTION LANG (1986) LTEE076157 EARTH SUPPORT SERVICES INC.076997 EXPERIOR GROUP INC

072436 FEDERAL EXPRESS CANADA LTD.075628 FORTUNE INVESTMENT CORP.

CORP. DE PLACEMENTS FORTUNE

074450 GEOFCOTT DEVELOPMENT LIMITED

072384 GEORGIA-PACIFIC RESINS, INC.074479 GERSHMAN TRANSPORT

INTERNATIONAL LTD.017731 GESCO INDUSTRIES INC.076150 GESTION D.G. GUIBAULT LTEE/

D.G. GUIBAULT HOLDINGS LTD.076571 GLOBAL ACCESS

COMMUNICATIONS INC.072423 GODAAR INVESTMENTS LTD.076139 GORDON PRIVATE CLIENT

CORPORATION070267 GUY F. ATKINSON HOLDINGS LTD.-

GESTION GUY F. ATKINSON LTEE075205 HAMILTON & SPILL LTD.018817 HILLSIDE AUTO CARRIER LTD.075641 HUNTER ENGINEERING COMPANY071790 HUNTERLINE TRUCKING LTD.073537 INFOPETRO HOME HEATING

CONSULTANTS GROUP072941 INTERTAPE POLYMER INC.018754 JAMES C. BROWN LTD.075646 KEDDY FATHOM INC.076508 KELTIC TRANSPORTATION INC.075209 LAIDLAW CARRIERS INC.018724 LAUZON SUPPLIES LIMITED075651 LEWISCRAFT CORPORATION076149 LILE MANAGEMENT SERVICES

LTD.071197 MARSHLAND AUTO PARTS

DISTRIBUTORS LTD.076159 MRDC OPERATIONS

CORPORATION018584 NORMAN WADE COMPANY

LIMITED073548 NPN DEALER MARKETING

ASSOCIATION LIMITED073983 Plum Creek Investment Company076114 PRODUCTION PRAXAIR CANADA

INC.018794 R. MOREAU & SON LOGGING LTD.071803 R.B.R. TRANSPORT INC.074802 RESSOURCES FREEWEST CANADA

INC./FREEWEST RESOURCES CANADA INC.

076138 SARGENT TRUCKING INC.074816 SECOND GLANCE INTERIORS LTD.073049 STOKES INC.073051 THE BARONS INCORPORATED076570 TRANSCOMMUNICATIONS

INCORPORATED071852 TRANSPORT BERNIERES INC.077487 TRI-LAC FORESTRY INC.075642 TRINKETS & TREASURES

RECYCLING LIMITED077982 UPM-Kymmene Canada Holdings

(2001) Inc.071218 W. H. SHURTLEFF COMPANY075629 WORLD FINANCIAL GROUP

INSURANCE AGENCY OF CANADA INC./

ALLIANCE MONDIALE DE PROMOTION COMMERCIALE DU CANADA INC.

077495 WORLDINSURE CANADA LIMITED

____________________

Notice of decisionto cancel the registration of extra-provincial corporations

Take notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to cancel the registration of the following extra-pro-vincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as thesaid corporations have been in default in sending to the Director fees,notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 daysafter the publication of this Notice in The Royal Gazette, the Directormay cancel the registration.

____________________

Avis d’une décisiond’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de laLoi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir auDirecteur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez aviséque 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Ga-zette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites cor-porations extraprovinciales.

____________________________________________________

Page 8: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1238 Gazette royale — 26 novembre 2003

608737 N.B. LTD. 469, rue Main Street Moncton 608737 2003 10 21Moncton, NB E1C 1C2

608824 N.B. Ltd. 4, avenue Cambridge Avenue Quispamsis 608824 2003 10 20Quispamsis, NB E2E 4W7

608855 N.B. LTD. 48, rue Bonaccord Street Moncton 608855 2003 10 14Moncton, NB E1C 5K7

608856 NB Ltée 283, boulevard J.-D.-Gauthier Boulevard Shippagan 608856 2003 10 17Shippagan, NB E8S 1N6

608857 NB Ltée 283, boulevard J.-D.-Gauthier Boulevard Shippagan 608857 2003 10 17Shippagan, NB E8S 1N6

608858 NB Ltée 283, boulevard J.-D.-Gauthier Boulevard Shippagan 608858 2003 10 17Shippagan, NB E8S 1N6

Northern Data Communication Inc. 3297, route / Highway 180 South Tetagouche 608952 2003 10 14South Tetagouche, NB E2A 7C3

NOEL DEVELOPERS LTD. 305, rue Thibodeau Street Dieppe 608998 2003 10 16Dieppe, NB E1A 1W1

609018 N.B. Inc. 6090, route / Highway 112 New Canaan 609018 2003 10 22New Canaan, NB E4Z 6A8

J.J’s Shediac Discount Store Ltd. 16, rue Saint-Joseph Street Shediac 609060 2003 10 21Shediac, NB E4P 2R7

Dr. Amar N. Pal Professional Corporation Inc. 100, rue Arden Street, bureau / Suite 620 Moncton 609065 2003 10 21Moncton, NB E1E 4B7

EVER GROWTH INC. 255, rue Main Street Fredericton 609071 2003 10 22Fredericton, NB E3A 1E1

ST-ONGE LANDSCAPING LTD. 930, rue Main Street Grand-Sault / 609090 2003 10 23Grand-Sault / Grand Falls, NB E3Z 2X2 Grand Falls

609133 NB INC. 95, croissant Talisman Crescent Fredericton 609133 2003 10 31Fredericton, NB E3C 1L9

P & D DONAHUE & SONS LTD. 381, route / Highway 4 Harvey 609195 2003 10 30Harvey, NB E6K 1X3

CAMPBELLTON TAX SERVICES LTD 97, rue Fraser Street Plaster Rock 609250 2003 10 31Plaster Rock, NB E7G 4J6

Mindsbridge Corporation 570, rue Queen Street Fredericton 609259 2003 11 04C.P. / P.O. Box 1500Fredericton, NB E3B 5G2

609268 New Brunswick Inc. 660, avenue Rothesay Avenue, unité / Unit E Saint John 609268 2003 11 05Saint John, NB E2H 2H4

THE DRILLING DEPOT LTD. 3, allée Maple Ridge Lane Riverview 609281 2003 11 05Riverview, NB E1B 5N5

609283 N.B. Ltd. 22, croissant Cove Crescent Rothesay 609283 2003 11 05Rothesay, NB E2E 4Y5

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1239 Gazette royale — 26 novembre 2003

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on July 8, 2003 under the name of “L & O HOLDINGS LTD.”, being corporation #607556, notice is given that pur-suant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the names of the directors set out on Form 4.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 8 juillet 2003 à « L & O HOLDINGS LTD. », dont le numéro de corporationest 607556, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de constitution modifiant les noms des directeurs tels qu’ils apparaissentdans la formule 4.

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on August 12, 2003 under the name of “PDG CONSTUCTORS INCORPORATED”, being corporation #608067,notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the corporation from “PDGCONSTUCTORS INCORPORATED” to “PDG CONSTRUCTORS INCORPORATED”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 12 août 2003 à « PDG CONSTUCTORS INCORPORATED », dont le numéro decorporation est 608067, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de constitution faisant passer la raison sociale de la corpo-ration de « PDG CONSTUCTORS INCORPORATED » à « PDG CONSTRUCTORS INCORPORATED ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on June 24, 2003 under the name of “Haywood Enterprises Ltd.”, being corporation #607345, notice is given thatpursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the corporation number from “607345” to “607347”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 24 juin 2003 à « Haywood Enterprises Ltd. », dont le numéro de corporationest 607345, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de constitution faisant passer le numéro de corporation de « 607345 » à« 607347 ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on July 14, 2003 under the name of “607532 NB Ltd.”, being corporation #607532, notice is given that pursuant tos.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the corporation from “607532 NB Ltd.” to “607532 NB INC.”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 14 juillet 2003 à « 607532 NB Ltd. », dont le numéro de corporation est 607532, ledirecteur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de constitution faisant passer la raison sociale de la corporation de « 607532 NB Ltd. »à « 607532 NB INC. ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on September 30, 2003 under the name of “Maple Holdings Canada Limited”, being corporation #608728, noticeis given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation by replacing Form 1 of the Articles as it relates to the sharecapital.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 30 septembre 2003 à « Maple Holdings Canada Limited », dont le numéro decorporation 608728, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de constitution remplaçant la formule 1des statuts constitutifsayant trait au capital social.

_____________________________________________________

Goodfellow’s Trucking Ltd. Bureau / Suite B Miramichi Nouveau-Brunswick / 007274 2003 10 31305, avenue Dalton Avenue New BrunswickMiramichi, NB E1V 3C4

_____________________________________________________

CEDAR ACRES LTD. 003214 2003 11 04

DEXTER CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 004978 2003 10 31

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1240 Gazette royale — 26 novembre 2003

PARK HOUSE INN LTD. 012812 2003 11 03

LES PRODUCTIONS GRANA PRODUCTIONS INC. 510296 2003 10 22

Jannick Holdings Limited 511647 2003 10 31

Q1 LABS CANADA INC. 515687 2003 11 03

_____________________________________________________

BURNS AVENUE RESIDENTIAL INC. GREENARM STORAGE LTD. 507520 2003 10 28

HOLIDAY GROUP INC. Holiday Luggage (Canada) Inc./ 508689 2003 11 04GROUPE HOLIDAY INC. Bagages Holiday (Canada) Inc.

_____________________________________________________

LYLE BONGARD’S R.V. SALES LYLE BONGARD’S R.V. SALES 2410, ch. Woodstock Rd. Fredericton 609214 2003 11 01LTD. LTD. Fredericton, NB E3C 5C2

DOUGLAS DEVELOPMENTCORPORATION LTD.

DR. NATALY VO PROFESSIONAL Dr. Nataly Vo Professional Bureau / Suite 600 Fredericton 609234 2003 11 01CORPORATION Corporation 77, rue Westmorland Street

DR. NATALY VO HOLDINGS Fredericton, NB E3B 5B4LIMITED

Goodfellow’s Trucking Ltd. GOODFELLOW’S TRUCKING Bureau / Suite B Miramichi 609251 2003 11 01LTD. 305, avenue Dalton AvenueTARGET CONSTRUCTION LTD. Miramichi, NB E1V 3C4

_____________________________________________________

E. & R. AUTO SERVICE LTD. 3320, chemin Emmerson Hill Road South Tetagouche 056926 2003 10 28South Tetagouche, NB E2A 7H6

Cercueil Lauzière Inc. Lauzière Casket Inc. 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 Saint John 506090 2003 10 31C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1241 Gazette royale — 26 novembre 2003

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a restated certificate of incorporation issued on May 29, 2003 under the name of “Développement Carrefour de la Vallée Ltée/Ltd”, being corporation#606456, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected restated certificate of incorporation correcting the corporation number onForm 5 from “606456” to “510176”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 29 mai 2003 à « Développement Carrefour de la Vallée Ltée/Ltd », dont le numérode corporation est 606456, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de constitution faisant passer le numéro de corporationsur la formule 5 de « 606456 » à « 510176 ».

_____________________________________________________

POLLOCK LEASING INC. Ontario John Eric Pollabauer 609057 2003 10 20644, rue Main Street, bureau / Suite 601C.P. / P.O. Box 28051Moncton, NB E1C 9N4

11317 Newfoundland Inc. Terre-Neuve-et- Terrence W. Hutchinson 609186 2003 10 29Labrador / 40, rangée Wellington RowNewfoundland and C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ALabrador Saint John, NB E2L 4S3

1505028 ONTARIO LIMITED Ontario Gerald S. McMackin 609230 2003 10 3144, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

2002029 ONTARIO LIMITED Ontario Gerald S. McMackin 609231 2003 10 3144, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

2002028 ONTARIO LIMITED Ontario Gerald S. McMackin 609232 2003 10 3144, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

KIT Inc. Canada C. Paul W. Smith 609237 2003 10 3144, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of registration issued on June 26, 2000 under the name of “ANDLAUER TRANSPORTATION SERVICES INC.”, being corporation#077253, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of registration, correcting the corporate name from “AND-LAUER TRANSPORTATION SERVICES INC.” to “ATS ANDLAUER TRANSPORTATION SERVICES INC.”.

Sachez que, relativement au certificat d’enregistrement délivré le 26 juin 2000 à « ANDLAUER TRANSPORTATION SERVICES INC. », dont le numéro de cor-poration est 077253, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé d’enregistrement faisant passer la raison sociale de la corpora-tion de « ANDLAUER TRANSPORTATION SERVICES INC. » à « ATS ANDLAUER TRANSPORTATION SERVICES INC. ».

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a restated certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de constitution mise à jour a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1242 Gazette royale — 26 novembre 2003

CANADIAN CANADIAN UNDERGROUND 3200, rue 10180 – 101 Street D. Hayward Aiton 609055 2003 10 20UNDERGROUND EQUIPMENT INC. Edmonton, AB T5J 3W8 Stewart McKelveyEQUIPMENT INC. QUEBEC UNDERGROUND Stirling Scales

EQUIPMENT INC. Bureau / Suite 100044, côte Chipman HillC.P. / P.O. Box 7289Succursale / Station ASaint John, NB E2L 4S6

Effective Date of Amalgamation: July 31, 2003 / Date d’entrée en vigueur de la fusion : le 31 juillet 2003

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of registration of amalgamated corporation issued on December 6, 2001 under the name of “CIT Financial Ltd./Services Financiers CITLtée”, being corporation #077977, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of registration of amalgamated cor-poration, correcting the corporate number of an amalgamating corporation: “Newcourt Capital Inc. – N/A” to “Newcourt Capital Inc. - 075064”.

Sachez que, relativement au certificat d’enregistrement d’une corporation issue d’une fusion délivré le 6 décembre 2001 à « CIT Financial Ltd./Services FinanciersCIT Ltée », dont le numéro de corporation est 077977, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant ajouter le numéro decorporation à la raison sociale « Newcourt Capital Inc. – N/A » pour qu’elle se lise comme suit : « Newcourt Capital Inc. – 075064 ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of registration of amalgamated corporation issued on September 24, 2003 under the name of “Aliant Telecom Inc. / TelecommunicationsAliant Inc.”, being corporation #608645, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of registration of amalgam-ated corporation, correcting the name of an amalgamating corporation: “4180674 Canada In.” to “4180674 Canada Inc.”.

Sachez que, relativement au certificat d’enregistrement d’une corporation issue d’une fusion délivré le 24 septembre 2003 à « Aliant Telecom Inc. / Telecommunica-tions Aliant Inc. », dont le numéro de corporation est 608645, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé modifiant la raisonsociale de la corporation de « 4180674 Canada In. » à « 4180674 Canada Inc. ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of registration of amalgamated corporation issued on July 21, 2003 under the name of “GOODLIFE FITNESS CENTRES INC./VITAVIE CENTRES DE MISE EN FORME INC.”, being corporation #607786, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a cor-rected certificate of registration of amalgamated corporation, correcting the date of amalgamation from “July 21, 2003” to “July 1, 2003”.

Sachez que, relativement au certificat d’enregistrement d’une corporation issue d’une fusion délivré le 21 juillet 2003 à « GOODLIFE FITNESS CENTRES INC./VITAVIE CENTRES DE MISE EN FORME INC. », dont le numéro de corporation est 607786, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, uncertificat corrigé faisant passer la date de fusion du « 21 juillet 2003 » au « 1er juillet 2003 ».

FRATERNITÉ S.E.V.E. INC. 53, rue Williams Street Moncton 609023 2003 10 17Moncton, NB E1C 2G6

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Siège social référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1243 Gazette royale — 26 novembre 2003

TANTRAMAR HERITAGE TRUST INC. 024996 2003 10 17

_____________________________________________________

Atlantic Association of Professional International Academy of Naturotherapy Inc./ 025421 2003 10 17Naturotherapists Inc./ Académie Internationale de Naturothérapie Inc.Association des NaturothérapeutesProfessionnels de l’Atlantique Inc.

A CHILDS TREASURE CHEST Michelle Hammill 24, cour Snowdon Court 607665 2003 09 22Moncton, NB E1G 1K5

Golden Mile Diner 509770 N.B. Inc. 175, rue King Street 608385 2003 10 24Saint John, NB E2L 1G9

CAN-FAN RACE TOURS Aaron Cole 137, chemin Colpitts Road 609035 2003 10 20Colpitts Settlement, NB E4J 1A8

KUSTOM FINISHING 4U2C Gerald Poirier 1836, chemin Shediac River Road 609038 2003 10 21Shediac River, NB E4R 1X5

El-Roy Independent Sales Agents Raymond Boucher 573, chemin Weisner Road 609039 2003 10 21LakevilleComté de Westmorland County, NB

Angel Street Ministry John M. Larlee 245, promenade Parkside Drive, app. / Apt.10 609047 2003 10 22James Gilliatt Fredericton, NB E3B 5L7Chris Slauenwhite

Second City Clothing Tracy Berube 10, rue Tim Street 609062 2003 10 22Saint John, NB E2H 1X7

DOMAINE SHANGRILA ESTATES NICAL DEVELOPMENT 50, promenade Camelot Drive 609063 2003 10 21CORPORATION Moncton, NB E1A 1P6

Lincoln Lounge YOHAN ENTERPRISES LTD. 1769, chemin Lincoln Road 609161 2003 10 29Fredericton, NB E3B 8P4

Beaverdam Quiltery BEAVERDAM POOLS LTD. 759, rue Aberdeen Street 609181 2003 10 30Fredericton, NB E3B 1S7

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :

Reference Number Date

Numéro de Year Month DayName / Raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :

DateNew Name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1244 Gazette royale — 26 novembre 2003

ETELLIGENT SOLUTIONS Lushu Li 80, promenade Rebecca Drive 609185 2003 10 31CONSULTING Fredericton, NB E3B 9N4

COTTON WOODLOT Mike G. Cotton 1632, chemin Post Road 609201 2003 10 31Rusagonis, NB E3B 7Y3

John White Enterprises John White 42, avenue Stewart Avenue 609211 2003 10 31Sussex, NB E4E 2E6

Foreign Affairs Importing Jaynaya Allain 1035, rue Main Street 609212 2003 10 31Moncton, NB E1C 1G9

BEATER FLUSH CONSTRUCTION 608034 N.B. Ltd. 3, promenade Alderbrook Drive 609216 2003 11 03Quispamsis, NB E2E 5B3

GB Tek Controls Brenda Keith 4, cour Sunset Court 609246 2003 11 03Smiths Creek, NB E4G 2T9

SAINT JOHN LASER CLINIC PERFUMES PLUS LTD. 1, Market Square 609267 2003 11 05Saint John, NB E2L 4Z6

BUGLE ENTREPRISE Berthold Ulrich 10, rue Kent Street 609284 2003 11 06Lincoln, NB E3B 7E8

Sew it together Marie-May Kaffine 3, avenue Mark Avenue 609287 2003 11 06Rothesay, NB E2S 1A2

BAD AMY SCARE WEAR Charles Elgee 71, allée Cains Brook Lane 609288 2003 11 06New Maryland, NB E3C 1J3

Seb D Photography Sebastian Martin Domaradzki 33, allée Old Orchard Lane 609289 2003 11 06Riverview, NB E1B 5M5

Munlan Roofing Tiffany Munroe 46, chemin Royal Road, app. / Apt. 7 609304 2003 11 06Fredericton, NB E3A 4V1

PMF Ventures Pamela Fletcher 355, rue Oxford Street 609321 2003 11 07Fredericton, NB E3B 2W6

_____________________________________________________

THE SCHOLAR’S DEN William M. Brienza 105, rue Prince Edward Street 342625 2003 10 22Saint John, NB E2L 3S1

The Auction Barn CAMERON AUCTIONEERS & 857, route / Highway 8 345504 2003 10 22APPRAISERS LTD. Taymouth, NB E6C 2B5

The Auction Center CAMERON AUCTIONEERS & 857, route / Highway 8 345505 2003 10 22APPRAISERS LTD. Taymouth, NB E6C 2B5_____________________________________________________

CENTRAL CAB 21, promenade Colonial Drive 351015 2003 10 02Moncton, NB E1G 2J1

Northern Data Communication 3297, route / Highway 180 603610 2003 10 14South Tetagouche, NB E2A 7C3

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number Date

Registrant of Certificate Adresse du commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Enregistreur du certificat du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

DateAddress Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Adresse Numéro de référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1245 Gazette royale — 26 novembre 2003

Simple Organizing Solutions Elaine Marie Shannon 7, promenade Rivercrest Drive 609064 2003 10 21Susan Michelle Clark Quispamsis, NB E2E 1W4

GROUP EAST AND ASSOCIATES David Crossley 15, promenade Colonial Drive 609202 2003 11 04Brian Cornish Quispamsis, NB E2G 1A4

McLean’s Logging Jeffrey Clarence Wilson 1605, route / Highway 910 609210 2003 10 31Baxter Kim Wilson Turtle Creek, NB E1J 2E3

BROADBAND SOLUTIONS Joseph Charles Price 22, promenade Wilkie Drive 609255 2003 11 04Christopher Robin Doiron New Line, NB E4E 4T3

Boom! Nightclub Steven Arnold DeWitt 624, rue Queen Street 609266 2003 11 05Michael Earl Young Fredericton, NB E3B 1C2

SPAGO’S PIZZA Georgios Vlamakis 68, rue King Street 609280 2003 11 05Emmanouil Vlamakis Saint John, NB E2L 4R8

STEF - I Ventures Stephanie Mae Hoekman 289, route / Highway 610 609285 2003 11 06Isabelle Grant Upper Hainesville, NB E6E 1K9

_____________________________________________________

BUGLE ENTREPRISE 10, rue Kent Street 340927 2003 11 06Lincoln, NB E3B 7E8

Seneca New Brunswick Nouveau-Brunswick / Penn West Petroleum Ltd. Bureau / Suite 1000 400617 2003 10 14Limited Partnership New Brunswick 44, côte Chipman Hill

C.P. / P.O. Box 7289Succursale / Station ASaint John, NB E2L 4S6

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

DateAddress Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Adresse Numéro de référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1246 Gazette royale — 26 novembre 2003

NOTICE OF PUBLIC HEARINGNotice is given that a public hearing of the Municipal Capital Borrow-ing Board will be held - Monday December 8, 2003 at 2:00 p.m.,Marysville Place, Third Floor Conference Room, Fredericton, NB, tohear the following municipal application for authorization to borrowmoney for a capital expense:

Objections to these applications may be filed in writing or made to theBoard at the hearing - Secretary, Municipal Capital Borrowing Board,Marysville Place, P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick,E3B 5H1, FAX: 457-4991, TEL: 453-2154

If you require sign language interpretation or an assistive listeningdevice or FM system, please contact the Saint John Deaf & Hard ofHearing Services (TTY) (506) 634-8037.

File No.: B/M/81/03IN THE COURT OF QUEEN’S BENCHOF NEW BRUNSWICKTRIAL DIVISIONJUDICIAL DISTRICT OF BATHURST

IN THE MATTER OF THE QUIETING OF TITLES ACT,R.S.N.B. 1973, Chapter Q-4, as amended;-and-IN THE MATTER of the joint application of Ludger A. Basquethrough his curator to property Daniel Basque, Mario Basque,Daniel Basque and Germaine Sonier (McGraw) for a certificate oftitle to their respective lands located in Losier Settlement, in theCounty of Gloucester and Province of New Brunswick.

PUBLIC NOTICEUNDER THE QUIETING OF TITLES ACT

(Form 70B)

TO WHOM IT MAY CONCERN:The applicants, Ludger A. Basque through his curator to propertyDaniel Basque, Mario Basque, Daniel Basque and GermaineSonier (McGraw) will make an application before the Court ofQueen’s Bench of New Brunswick at 254 St. Patrick Street, Bathurst,New Brunswick, on the 15th day of December, 2003, at 9:30 a.m., fora certificate that they are respectively the owner of land located atLosier Settlement, in the County of Gloucester and Province ofNew Brunswick, the legal description of which land is set out inSchedule “A”.

Time Municipality Purpose Amount

2:05 p.m. Sussex Corner General Government ServicesFurniture and Equipment-Municipal Building $25,000

2:15 p.m. Chipman Recreation and Cultural ServicesZamboni Ice Resurfacer $76,000

Municipal CapitalBorrowing Act

Quieting of Titles Act

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUEAvis est donné par les présentes que la Commission des emprunts decapitaux par les municipalités tiendra une audience publique le lundi8 décembre 2003, à 14 h, à la salle de conférence du troisième étage dePlace Marysville, à Fredericton (Nouveau-Brunswick) pour entendrela demande des municipalités suivantes concernant l’autorisationd’emprunter pour des dépenses de capital :

Toute objection à ces demandes peut être présentée à la Commissionpar écrit ou de vive voix au moment de l’audience - Le secrétaire dela Commission des emprunts de capitaux par les municipalités,Place Marysville, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick)E3B 5H1, TÉLÉC. : 457-4991, TÉL. : 453-2154

Si vous avez besoin d’un service d’interprétation gestuelle ou d’un dis-positif technique pour malentendants (système FM), veuillez téléphonerau Saint John Deaf & Hard of Hearing Services au (506) 634-8037(ATS).

No de dossier : B/M/81/03COUR DU BANC DE LA REINEDU NOUVEAU-BRUNSWICKDIVISION DE PREMIERE INSTANCECIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE BATHURST

VU LA LOI SUR LA VALIDATION DES TITRES DE PRO-PRIÉTÉ, L.R.N.-B. de 1973, chap. Q-4 dans sa forme modifiée;- et -DANS L’AFFAIRE de la requête conjointe de Ludger A. Basquepar son curateur de biens Daniel Basque, Mario Basque, DanielBasque et Germaine Sonier (McGraw) en vue d’obtenir un certifi-cat de titre de propriété sur leurs biens-fonds respectifs situés àLosier Settlement, dans le comté de Gloucester, province duNouveau-Brunswick.

AVIS AU PUBLICEN APPLICATION DE LA LOI SUR LA

VALIDATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ(Formule 70B)

A QUI DE DROITLes requérants, Ludger A. Basque par son curateur de biens DanielBasque, Mario Basque, Daniel Basque et Germaine Sonier(McGraw) présenteront une requête à la Cour à Bathurst,Nouveau-Brunswick, le 15 décembre, 2003, à 9 h 30, au 254, rueSt. Patrick, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, àBathurst, Nouveau-Brunswick, en vue d’obtenir un certificat attestantqu’ils sont respectivement, le propriétaire des biens-fonds situés àLosier Settlement, dans le comté de Gloucester, dans la province duNouveau-Brunswick, et dont une description figure à l’annexe « A ».

Heure Municipalité But Montant

14 h 05 Sussex Corner Services d’administration généraleÉquipment et réparations-Édifice municipal 25 000 $

14 h 15 Chipman Services récréatifs et culturelsZamboni - resurfaceuse 76 000 $

Loi sur les emprunts decapitaux par les municipalités

Loi sur la validationdes titres de propriété

Page 17: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1247 Gazette royale — 26 novembre 2003

If any person claims an interest in such land, or any part thereof, hemust appear at the hearing of the application at the place and timestated, either in person or by a New Brunswick lawyer acting on hisbehalf.Any person who intends to appear at the hearing of the application andwishes to present evidence to support his position must, no later thanthe 8th day of December, 2003,

(a) file a statement of adverse claim, verified by affidavit, in theoffice of the clerk of the Judicial District of Bathurst, at 254St. Patrick Street, P.O. Box 5001, Bathurst, N.B., and

(b) serve a copy thereof on the applicants’ lawyer, Mr. Eric P. Sonier,of Sonier Robichaud Duguay, Barristers and Solicitors, at 1-3623Principale Street, Tracadie-Sheila, N.B. E1X 1C9.

The claim of any person who does not file and serve an adverse claimwill be barred and the title of the applicants will become absolute, sub-ject to the exceptions and qualifications mentioned in paragraphs18(1)(a), (b) and (e) of the Quieting of Titles Act.Adverse claimants are advised that:

(a) they are entitled to issue documents and present evidence in theproceeding in English or French or both;

(b) the applicants intend to proceed in the French language; and(c) an adverse claimant who requires the services of an interpreter at

the hearing must so advise the clerk upon filing an adverse claim.

THIS NOTICE is signed and sealed for the Court of Queen’s Benchby Donald Arseneau, Clerk of the Court at Bathurst, New Brunswick,on the 5th day of November, 2003.

Donald Arseneau, Court of Queen’s Bench, Court House, 54 St. PatrickStreet, P.O. Box 5001, Bathurst, N.B. E2A 3Z9

Schedule “A”Lot #1 and Lot #4:Ludger Basque and Ludger A. Basque through his curator toproperty Daniel BasquePID: 20132171 and 20138913 and 20131199ALL THOSE certain lots, pieces or parcels of land situate, lying andbeing in Losier Settlement, in the Parish of Saumarez, in the County ofGloucester and Province of New Brunswick, more particularly de-scribed as follows:BEING Lot #1 and Lot #4 of the LUDGER BASQUE ET AL surveyplan, as prepared by Brian Sisk, N.B.L.S., on August 25, 2003;THE SAID plan having been approved by C.A.P.A. on October 7,2003;THE SAID plan having been filed with the Office of the Registrar ofDeeds in and for the County of Gloucester on October 7, 2003, as offi-cial number 17204943;

Lot #2:Germaine Sonier (McGraw), PID: 20149258ALL THAT certain lot, piece or parcel of land situate, lying and beingin Losier Settlement, in the Parish of Saumarez, in the County ofGloucester and Province of New Brunswick, more particularly de-scribed as follows:BEING Lot #2 of the LUDGER BASQUE ET AL survey plan, as pre-pared by Brian Sisk, N.B.L.S., on August 25, 2003;THE SAID plan having been approved by C.A.P.A. on October 7,2003;THE SAID plan having been filed with the Office of the Registrar ofDeeds in and for the County of Gloucester on October 7, 2003, as offi-cial number 17204943;

Quiconque prétend posséder un titre ou un droit sur lesdits biens-fondsou une partie de ceux-ci est tenu, de comparaître à l’audition de la re-quête aux lieu, date et heure indiqués, en personne ou par l’intermé-diaire d’un avocat du Nouveau-Brunswick chargé de le représenter.Quiconque a l’intention de comparaître à l’audition de la requête etdésire présenter une preuve en sa faveur est tenu, au plus tard le8 décembre, 2003,

a) déposer au greffe de la circonscription judiciaire de Bathurst, au254, rue St-Patrick, Case postale 5001, Bathurst, N.-B., un exposéde sa demande contraire attesté par affidavit; et

b) d’en signifier copie à l’avocat de la requérante, Me Eric P. Sonier,de Sonier Robichaud Duguay, avocats-notaires, 1-3623 rue Prin-cipale, Tracadie Sheila, N.B. E1X 1C9.

La demande de quiconque omet de déposer et de signifier une demandecontraire, sera jugée irrecevable et le titre de la requérante deviendraabsolu, sous réserve des exceptions et réserves prévues au paragraphe18(1)a), b) et e) de la Loi sur 1a validation des titres de propriété.Les opposants sont avisés que :

a) dans la présente instance, ils ont le droit d’émettre des documentset de présenter leur preuve en français, en anglais ou dans les deuxlangues;

b) les requérants ont l’intention d’utiliser la langue française;c) s’ils comptent avoir besoin des services d’un interprète à

l’audience, ils devront en aviser le greffier au moment du dépôtde leur demande contraire.

CET AVIS est signé et scellé au nom de la Cour du Banc de la Reinepar Donald Arseneau, greffier de la Cour, à Bathurst,Nouveau-Brunswick, le 5 novembre 2003.

Donald Arseneau, Cour du Banc de la Reine, Palais de Justice, 54, rueSt-Patrick, case postale 5001, Bathurst, N.-B. E2A 3Z9

Annexe « A »Lot #1 et Lot #4 :Ludger Basque et Ludger A. Basque, par son curateur de biensDaniel BasqueNid : 20132171 et 20138913 et 20131199TOUTES LES PARCELLES de terrain situées à Losier Settlement,paroisse de Saumarez, comté de Gloucester et province duNouveau-Brunswick, plus précisément décrites comme suit :

ÉTANT les Lot #1 et Lot #4 du plan d’arpentage LUDGER BASQUEET AL tel que préparé par Brian Sisk, A.G.N.B., le 25 août 2003;LEDIT plan ayant été approuvé par C.A.P.A le 7 octobre 2003;

LEDIT plan ayant été déposé auprès du Conservateur des Titres danset pour le comté de Gloucester le 7 octobre 2003 sous le Numéro offi-ciel 17204943;

Lot #2 :Germaine Sonier (McGraw), Nid : 20149258TOUTE LA PARCELLE de terrain située à Losier Settlement,paroisse de Saumarez, comté de Gloucester et province duNouveau-Brunswick, plus précisément décrite comme suit :

ÉTANT le Lot #2 du plan d’arpentage LUDGER BASQUE ET AL telque préparé par Brian Sisk, A.G.N.B., le 25 août 2003;LEDIT plan ayant été approuvé par C.A.P.A le 7 octobre 2003;

LEDIT plan ayant été déposé auprès du Conservateur des Titres danset pour le comté de Gloucester le 7 octobre 2003 sous le Numéro offi-ciel 17204943;

Page 18: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1248 Gazette royale — 26 novembre 2003

Lot #3:Daniel Basque, PID: 20149753ALL THAT certain lot, piece or parcel of land situate, lying and beingin Losier Settlement, in the Parish of Saumarez, in the County ofGloucester and Province of New Brunswick, more particularly de-scribed as follows:BEING Lot #3 of the LUDGER BASQUE ET AL survey plan, as pre-pared by Brian Sisk, N.B.L.S., on August 25, 2003;THE SAID plan having been approved by C.A.P.A. on October 7,2003;THE SAID plan having been filed with the Office of the Registrar ofDeeds in and for the County of Gloucester on October 7, 2003, as offi-cial number 17204943;

Lot #5:Mario Basque, PID: 20131207ALL THAT certain lot, piece or parcel of land situate, lying and beingin Losier Settlement, in the Parish of Saumarez, in the County ofGloucester and Province of New Brunswick, more particularly de-scribed as follows:BEING Lot #5 of the LUDGER BASQUE ET AL survey plan, as pre-pared by Brian Sisk, N.B.L.S., on August 25, 2003;THE SAID plan having been approved by C.A.P.A. on October 7,2003;THE SAID plan having been filed with the Office of the Registrar ofDeeds in and for the County of Gloucester on October 7, 2003, as offi-cial number 17204943;

_________________

Court File No. S/M/81/03

IN THE COURT OF QUEEN’S BENCHOF NEW BRUNSWICKTRIAL DIVISIONJUDICIAL DISTRICT OF SAINT JOHN

UNDER THE QUIETING OF TITLES ACT

BETWEEN:THERESA MARIE TAYLOR, ROGER E. SPEAR, JR., JOYCEMARSHALL AND EDWARD H. DAWSON JR.

ApplicantsandLEWIS HERBERT STODDARD AND FREDA STODDARD,EXECUTORS OF THE ESTATE OF MILDRED HAUGHN,ESTATE OF JOHN S. BROWNRIGG

Respondents

PUBLIC NOTICEUNDER THE QUIETING OF TITLES ACT

(FORM 70B)

TO: ESTATE OF MILDRED HAUGHN, ESTATE OF JOHN S.BROWNRIGG, CEBACOB HOLDINGS LTD, AND WHO IT MAYCONCERNTheresa Marie Taylor, Roger E. Spear Jr., Joyce Marshall and EdwardH. Dawson Jr. will make an application before the Court at 110 Char-lotte Street, Saint John, New Brunswick, on the 5th day of January,2004 at 12:00 noon for a certificate that they are the owners of landslocated at Bocabec Cove, New Brunswick, the legal description ofwhich lands is set out in Schedule “A”.If any person claims an interest in such land, or any part thereof, hemust appear at the hearing of the application at the place and timestated, either in person or by a New Brunswick lawyer acting on hisbehalf.

Lot #3 :Daniel Basque, Nid : 20149753TOUTE LA PARCELLE de terrain située à Losier Settlement,paroisse de Saumarez, comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick, plus précisément décrite comme suit :

ÉTANT le Lot #3 du plan d’arpentage LUDGER BASQUE ET AL telque préparé par Brian Sisk, A.G.N.B., le 25 août 2003;LEDIT plan ayant été approuvé par C.A.P.A le 7 octobre 2003;

LEDIT plan ayant été déposé auprès du Conservateur des Titres danset pour le comté de Gloucester le 7 octobre 2003 sous le Numéro offi-ciel 17204943;

Lot # 5 :Mario Basque, Nid : 20131207TOUTE LA PARCELLE de terrain située à Losier Settlement,paroisse de Saumarez, comté de Gloucester et province duNouveau-Brunswick, plus précisément décrite comme suit :

ÉTANT le Lot #5 du plan d’arpentage LUDGER BASQUE ET AL telque préparé par Brian Sisk, A.G.N.B., le 25 août 2003;LEDIT plan ayant été approuvé par C.A.P.A le 7 octobre 2003;

LEDIT plan ayant été déposé auprès du Conservateur des Titres danset pour le comté de Gloucester le 7 octobre 2003 sous le Numéro offi-ciel 17204943;

__________________

N° du dossier : S/M/81/03

COUR DU BANC DE LA REINEDU NOUVEAU-BRUNSWICKDIVISION DE PREMIÈRE INSTANCECIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAINT JOHN

EN VERTU DE LA LOI SUR LA VALIDATION DES TITRES DEPROPRIÉTÉENTRE :

THERESA MARIE TAYLOR, ROGER E. SPEAR FILS, JOYCEMARSHALL ET EDWARD H. DAWSON FILS

Requérantset LEWIS HERBERT STODDARD ET FREDA STODDARD, EXÉ-CUTEURS DE LA SUCCESSION DE MILDRED HAUGHN ETDE CELLE DE JOHN S. BROWNRIGG

Défendeurs

AVIS AU PUBLICEN APPLICATION DE LA LOI SUR LA

VALIDATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ(FORMULE 70B)

À QUI DE DROIT

Theresa Marie Taylor, Roger E. Spear fils, Joyce Marshall et EdwardH. Dawson fils présenteront une requête à la Cour, au 110, rue Char-lotte, Saint John (Nouveau-Brunswick), le 5 janvier 2004, à 12 h, envue d’obtenir un certificat attestant qu’ils sont les propriétaires des ter-rains situés à Bocabec Cove, au Nouveau-Brunswick, et dont une des-cription figure à l’annexe « A ».Quiconque prétend posséder un droit sur lesdits terrains ou une partiede ceux-ci est tenu de comparaître à l’audition de la requête aux lieu,date et heure indiqués, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocatdu Nouveau-Brunswick chargé de le représenter.

Page 19: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1249 Gazette royale — 26 novembre 2003

Any person who intends to appear at the hearing of the application andwishes to present evidence to support his position must, no later thanthe 31st day of December, 2003.

(a) file a statement of adverse claim, verified by affidavit, togetherwith a copy of any documentary evidence, in the office of theclerk of the Judicial District of Fredericton, at the address shownbelow, and

(b) serve a copy thereof on the applicant’s lawyer A. GordonShepard, 930 Prospect Street, Fredericton, New Brunswick.

The claim of any person who does not file and serve an adverse claimwill be barred and the title of the applicant will become absolute, sub-ject only to the exceptions and qualification mentioned in subsection18(1) of the Quieting of Titles Act (or as may be).

Adverse claimants are advised that:(a) they are entitled to issue documents and present evidence in the

proceeding in English or French or both;

(b) the applicant intends to proceed in the English language; and(c) an adverse claimant who requires the services of an interpreter at

the hearing must so advise the clerk upon filing an adverse claim.

THIS NOTICE is signed and sealed for the Court of Queen’s Bench byGeorge S. Theriault Clerk of the Court at 110 Charlotte Street, SaintJohn, New Brunswick, E2L 4Y9 on the 6th day of November, 2003.

George S. Thériault, clerk, P.O. Box 5001, 110 Charlotte Street, SaintJohn, NB E2L 4Y9

SCHEDULE “A”All those lands and premises described in Deed No. 93405, Book 274,Page l and situate on the south side of Highway 127 at Bocabec Cove,Charlotte County, New Brunswick having Property AccountNo. (PAN) 1374478 and having been assigned PID No. 01249366.

All those lands and premises described in Deed No.10606, Book 349,Page 591 and situate on the south side of Highway 127 at BocabecCove, Charlotte County, New Brunswick having Property AccountNo. (PAN) 1374698 and having been assigned PID No. 15068505.

All those lands and premises described in Deed No. 83957, Book 239,Page 874 and situate on the south side of Highway 127 at BocabecCove, Charlotte County, New Brunswick having Property AccountNo. (PAN) 1374305 and having been assigned PID No. 15068497.

All those lands and premises described in Deed No. 84406, Book 241,Page 577 and situate on the south side of Highway 127 at BocabecCove, Charlotte County, New Brunswick having Property AccountNo. (PAN) 1377620 and having been assigned PID No. 15068489.

All those lands and premises described in Deed No. 84405, Book 241,Page 574 and situate on the south side of Highway 127 at BocabecCove, Charlotte County, New Brunswick having Property AccountNo. (PAN) 1377612 and having been assigned PID No. 15068463.

All those lands and premises described in Deed No. 49502, Book 148,Page 677 and situate on the south side of Highway 127 at BocabecCove, Charlotte County, New Brunswick having Property AccountNo. (PAN) 1372175 and having been assigned PID No. 15068471.

Quiconque a l’intention de comparaître à l’audition de la requête et dé-sire présenter une preuve en sa faveur est tenu, au plus tard le 31 dé-cembre 2003,

a) de déposer au greffe de la circonscription judiciaire de Saint John,à l’adresse indiquée ci-dessous, un exposé de sa demande con-traire attesté par affidavit accompagné d’une copie de toutepreuve littérale; et

b) d’en signifier copie à l’avocat des requérants, Me A. GordonShepard, 930, rue Prospect, Fredericton (Nouveau-Brunswick).

La demande de quiconque omet de déposer et de signifier une demandecontraire sera jugée irrecevable et le titre des requérants deviendra ab-solu, sous la seule réserve des exceptions et réserves prévues au para-graphe 18(1) de la Loi sur la validation des titres de propriété (ou selonle cas).Les opposants sont avisés que :

a) dans la présente instance, ils ont le droit d’émettre des documentset de présenter leur preuve en anglais, en français ou dans les deuxlangues;

b) les requérants ont l’intention d’utiliser la langue anglaise; etc) s’ils comptent avoir besoin des services d’un interprète à

l’audience, ils doivent en aviser le greffier au moment du dépôtd’une demande contraire.

CET AVIS est signé et scellé au nom de la Cour du Banc de la Reinepar George S. Thériault, greffier de la Cour au 110, rue Charlotte, SaintJohn (Nouveau-Brunswick) E2L 4Y9, le 6 novembre 2003.

George S. Thériault, greffier, 110, rue Charlotte, C.P. 5001, Saint John(Nouveau-Brunswick) E2L 4Y9

ANNEXE « A »Tout le terrain, y compris ses bâtiments, désigné dans l’acte de transfertn° 93405, à la page 1 du registre 274, et situé du côté sud de laroute 127 à Bocabec Cove, comté de Charlotte, province duNouveau-Brunswick, et dont le numéro de compte est 1374478 et lenuméro d’identification 01249366.Tout le terrain, y compris ses bâtiments, désigné dans l’acte de transfertn° 10606, à la page 591 du registre 349, situé du côté sud de la route127 à Bocabec Cove, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro de compte est 1374698 et le numérod’identification 15068505.Tout le terrain, y compris ses bâtiments, désigné dans l’acte de transfertn° 83957, à la page 874 du registre 239, situé du côté sud de la route127 à Bocabec Cove, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro de compte est 1374305 et le numérod’identification 15068497.Tout le terrain, y compris ses bâtiments, désigné dans l’acte de transfertn° 84406, à la page 577 du registre 241, situé du côté sud de la route127 à Bocabec Cove, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro de compte est 1377620 et le numérod’identification 15068489.Tout le terrain, y compris ses bâtiments, désigné dans l’acte de transfertn° 84405, à la page 574 du registre 241, situé du côté sud de la route127 à Bocabec Cove, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro de compte est 1377612 et le numérod’identification 15068463.Tout le terrain, y compris ses bâtiments, désigné dans l’acte de transfertn° 49502, à la page 677 du registre 148, situé du côté sud de la route127 à Bocabec Cove, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro de compte est 1372175 et le numérod’identification 15068471.

Page 20: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1250 Gazette royale — 26 novembre 2003

NOTICE UNDER THE CRIMINAL CODE OF CANADADESIGNATION

QUALIFIED TECHNICIAN – BREATH SAMPLESUnder the authority of subsection 254(1) of the Criminal Code ofCanada, I HEREBY DESIGNATE AS “qualified technician” qualifiedto operate an approved instrument for purposes of prosecutions underthe Criminal Code of Canada, the following persons:

DATED in the City of Fredericton, this 23rd day of October, 2003.

O. Wayne Steeves, Minister of Public SafetyProvince of New Brunswick

LOCATION NAMECanada Customs Revenue

AgencyPeter Warren Russell

Canada Customs Revenue Agency

Gregory J. Smythe

Department ofPublic Safety

AVIS EN VERTU DU CODE CRIMINEL DU CANADADÉSIGNATION

TECHNICIEN QUALIFIÉ – ÉCHANTILLONS D’HALEINEEn vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel du Canada, JE DÉSI-GNE PAR LES PRÉSENTES la personne suivante « technicienqualifié » habilité à manipuler un alcootest approuvé aux fins de pour-suites engagées pour l’application du Code criminel du Canada :

FAIT dans la cité de Fredericton le 23 octobre, 2003.

O. Wayne Steeves, ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick

ENDROIT NOMAgence des douanes

et du revenu du CanadaPeter Warren Russell

Agence des douanes et du revenu du Canada

Gregory J. Smythe

Ministère de laSécurité publique

Page 21: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1251 Gazette royale — 26 novembre 2003

PROVINCE OF NEW BRUNSWICKCOUNTY OF GLOUCESTERTO: MAUREEN HACHEY of Robertville, in the County of Glouc-ester and Province of New Brunswick;PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., Trustee in bankruptcy;CITIFINANCIAL (formerly Associates Mortgage East Corpora-tion), Mortgagee;AND ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold property situate at Robertville, in the County of Gloucesterand Province of New Brunswick.Sale by virtue of the power of sale contained in the mortgage and theProperty Act.Notice of sale given by the National Bank of Canada, first mortgagee.

Sale on December 5, 2003, at 11:00 a.m., local time, at the CaraquetTown Hall, located at 10 Du Colisée Street, Caraquet, in the County ofGloucester, New Brunswick. See advertisement in L’Acadie Nouvelle.

Brian G. Paquette, Solicitor for the National Bank of Canada

_________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: James Arthur Gardiner and Teresa Lynn Gardiner, original Mort-gagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to termsof the Mortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsas amended. Freehold property being situated at 5 Piercy Lane,McAdam, New Brunswick, PID Number 01528892.

Notice of sale given by J. W. Beesley. Sale to be held at the Office ofJohn S. MacPhee, 518 Central Court, Fredericton, New Brunswick, onthe 15th day of December, 2003, at the hour of 1:00 o’clock p.m., localtime. See advertisement in The Daily Gleaner.

John S. MacPhee, Solicitor for J. W. Beesley, Per: John S. MacPhee,518 Central Court, Fredericton, New Brunswick E3B 3N2, Telephone:(506) 458-1085, Facsimile: (506) 458-2719

_________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1

TO: Mario Quimpere (also known as Joseph Mario Quimpere andMario Yvan Quimpere); to all others to whom it may concern; and theRoyal Bank of Canada, present holder of the mortgage. Sale under theprovisions of a collateral mortgage dated October 26, 1999, and regis-tered in the Madawaska County Registry Office on the 26th day ofOctober, 1999, under the Official Number 10582204 (the “Mortgage”)and under the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, s.44. Freeholdproperty at Saint-Basile, in the County of Madawaska and Province ofNew Brunswick, described by PID No. 35265404 and PAN 03697505and known as 25 Damase Street, Saint-Basile, New Brunswick.

Notice of sale is given by the Royal Bank of Canada holder of theMortgage. Sale on Friday, December 19, 2003, at 2:00 o’clock in theafternoon by public auction in the lobby of the Court House, 121

Notices of Sale

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICKCOMTÉ DE GLOUCESTERDESTINATAIRES : MAUREEN HACHEY, de Robertville, comtéde Gloucester, province du Nouveau-Brunswick;PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., syndic en faillite;CITIFINANCIAL (anciennement Associates Mortgage EastCorporation), créancier hypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Bien en tenure libre situé à Robertville, dans le comté de Gloucester,province du Nouveau-Brunswick.Vente effectuée en vertu du pouvoir de vente contenu dans l’acte d’hy-pothèque et de la Loi sur les biens.Avis de vente donné par la Banque Nationale du Canada, premièrecréancière hypothécaire.La vente aura lieu le 5 décembre 2003, à 11 h de l’avant-midi, heurelocale, à l’hôtel de ville de Caraquet, situé au 10, rue du Colisée, àCaraquet, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick. Voirl’annonce publiée dans L’Acadie Nouvelle.

Brian G. Paquette, avocat de la Banque Nationale du Canada

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : James Arthur Gardiner et Teresa Lynn Gardiner, débi-teurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Venteeffectuée conformément aux dispositions de l’acte d’hypothèque et decelles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenurelibre situés au 5, allée Piercy, McAdam (Nouveau-Brunswick); NID :01528892.Avis de vente donné par J. W. Beesley. La vente aura lieu le 15 décem-bre 2003, à 13 h, heure locale, au bureau de John S. MacPhee, 518, courCentral, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiéedans The Daily Gleaner.

John S. MacPhee, avocat de J. W. Beesley, 518, courCentral, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 3N2; téléphone :(506) 458-1085; télécopieur : (506) 458-2719

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1

DESTINATAIRES : Mario Quimpere (également connu sous les nomsde Joseph Mario Quimpere et de Mario Yvan Quimpere); la BanqueRoyale du Canada, titulaire actuelle de l’hypothèque; et tout autre in-téressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acted’hypothèque subsidiaire établi le 26 octobre 1999 et enregistré au bu-reau de l’enregistrement du comté de Madawaska le 26 octobre 1999,sous le numéro 10582204 (l’« hypothèque »), et de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés à Saint-Basile, comté de Madawaska, province du Nouveau-Brunswick, dési-gnés par le numéro d’identification 35265404 et le numéro de compte03697505, et connus comme le 25, rue Damase, Saint-Basile(Nouveau-Brunswick).Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire del’hypothèque. La vente aux enchères publiques aura lieu le vendredi19 décembre 2003, à 14 h, dans le foyer du palais de justice, 121, rue

Avis de vente

Page 22: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1252 Gazette royale — 26 novembre 2003

Church Street, Edmundston, N.B. E3V 3L3. See advertisements inLe Madawaska.

Royal Bank of Canada, holder of the Mortgage by Hugh J. Cameron,Stewart McKelvey Stirling Scales, Solicitors for the Royal Bank ofCanada

_________________

To: Janet Louise Walker, of 148 McNair Drive, in the City ofFredericton, in the County of York and Province of New Brunswick,Mortgagor;And To: Irving Oil Limited, P.O. Box 1421, Saint John, NewBrunswick, E2L 4K1, Judgment Creditor;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 148 McNair Drive, in theCity of Fredericton, in the County of York and Province of NewBrunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the firstmortgage.Sale on the 7th day of January, 2004, at 10:00 a.m., at the Court Housein Fredericton, 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick. Seeadvertisement in The Daily Gleaner.

Clark Drummie, Solicitors for the mortgagee, the Royal Bank ofCanada

_________________

JOSEPH HENRY, Owner of the Equity of Redemption and CIBCMORTGAGE CORPORATION, Mortgagee and holder of the Mort-gage. Sale conducted under the terms of the Mortgage and the PropertyAct, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situ-ate at Upper Mills, in the Parish of Saint Stephen, in the County ofCharlotte and Province of New Brunswick. Notice of sale given by theabove holder of the Mortgage. Sale at the Charlotte County RegistryOffice, 73 Milltown Boulevard, in the Town of St. Stephen, in theCounty of Charlotte and Province of New Brunswick, on Tuesday, the16th day of December, A. D., 2003, at the hour of 10:00 o’clock in theforenoon, local time. See advertisement in the New BrunswickTelegraph-Journal in the issues of November 13, 20, 27 and December4, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC MortgageCorporation

_________________

Michael W. Jefferies and Jean E. Jefferies, spouse of Michael W.Jefferies, Owners of the Equity of Redemption and Original Mort-gagor; and CIBC Mortgage Corporation, Mortgagee and holder of theMortgage. Sale conducted under the terms of the Mortgage and theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold prop-erty situate at 369 Damascus Road, Damascus, in the Parish ofHampton, in the County of Kings and Province of New Brunswick.Notice of sale given by the above holder of the Mortgage. Sale at theCounty Court House, Main Street, in the Town of Hampton, in theCounty of Kings and Province of New Brunswick on Wednesday, the17th day of December, A.D. 2003, at the hour of 10:00 o’clock in theforenoon, local time. See advertisement in the New BrunswickTelegraph-Journal in the issues of November 17, 24, December 1 and8, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC Mortgage Corpo-ration

_________________

de l’Église, Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V 3L3. Voir l’an-nonce publiée dans Le Madawaska.

La Banque Royale du Canada, titulaire de l’hypothèque, par son avo-cat, Hugh J. Cameron, du cabinet Stewart McKelvey Stirling Scales

__________________

Destinataires : Janet Louise Walker, 148, promenade McNair, cité deFredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débi-trice hypothécaire;Et Irving Oil Limited, C.P. 1421, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4K1, créancier sur jugement;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 148, promenade McNair, cité deFredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de lapremière hypothèque.La vente aura lieu le 7 janvier 2004, à 10 h, au palais de justice deFredericton, 427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voirl’annonce publiée dans The Daily Gleaner.

Clark Drummie, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

__________________

JOSEPH HENRY, propriétaire du droit de rachat, et LA SOCIÉTÉD’HYPOTHÈQUES CIBC, créancière hypothécaire et titulaire del’hypothèque. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19,art.44. Biens en tenure libre situés à Upper Mills, paroisse de SaintStephen, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick. Avisde vente donné par la susdite titulaire de l’hypothèque. La vente auralieu le mardi 16 décembre 2003, à 10 h, heure locale, au bureau de l’en-registrement du comté de Charlotte, 73, boulevard Milltown, ville deSt. Stephen, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick.Voir l’annonce publiée dans les éditions des 13, 20 et 27 novembre etdu 4 décembre 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la créancière hypothécaire, la Société d’hy-pothèques CIBC

__________________

Michael W. Jefferies et Jean E. Jefferies, conjointe de Michael W.Jefferies, propriétaires du droit de rachat et débiteurs hypothécairesoriginaires; la Société d’hypothèques CIBC, créancière hypothécaire ettitulaire de l’hypothèque. Vente effectuée en vertu des dispositions del’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 369, chemin Damascus,Damascus, paroisse de Hampton, comté de Kings, province duNouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titulaire del’hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 17 décembre 2003, à 10 h,heure locale, au palais de justice du comté, rue Main, ville de Hampton,comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce pu-bliée dans les éditions des 17 et 24 novembre et des 1er et8 décembre 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la créancière hypothécaire, la Société d’hy-pothèques CIBC

__________________

Page 23: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1253 Gazette royale — 26 novembre 2003

PETER DAVID WILSON and BARBARA ANN WILSON, Ownersof the Equity of Redemption; CIBC MORTGAGES INC., Mortgageeand holder of the Mortgage; DAVID GORDON WILSON, Guarantor;and GREYSTONE TERRACE LTD., holder of the Second Mortgage.Sale conducted under the terms of the Mortgage and the Property Act,R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at91 Inglewood Drive, in the Town of Grand Bay-Westfield, in theCounty of Kings and Province of New Brunswick. Notice of sale givenby the above holder of the Mortgage. Sale at the Kings County CourtHouse, 2-648 Main Street, Hampton, New Brunswick on Monday, the15th day of December, A.D., 2003, at the hour of 10:15 o’clock in theforenoon, local time. See advertisement in the New BrunswickTelegraph-Journal in the issues of November 13, 20, 27 and December4, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC Mortgages Inc.

_________________

KIMBERLY ANN BOWES, Owner of the Equity of Redemption; andCIBC MORTGAGES INC., Mortgagee and holder of the Mortgage.Sale conducted under the terms of the Mortgage and the Property Act,R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at26 Meadow Avenue, in the Town of Hampton, in the County of Kingsand Province of New Brunswick. Notice of sale given by the aboveholder of the Mortgage. Sale at the Kings County Court House, 2-648Main Street, Hampton, New Brunswick on Monday, the 15th day ofDecember, A.D., 2003, at the hour of 10:00 o’clock in the forenoon, lo-cal time. See advertisement in the New Brunswick Telegraph-Journalin the issues of November 13, 20, 27 and December 4, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC Mortgages Inc.

_________________

PETER DAVID WILSON and BARBARA ANN WILSON, Ownersof the Equity of Redemption; CIBC MORTGAGES INC., Mortgageeand holder of the Mortgage; DAVID GORDON WILSON, Guarantor;GREYSTONE TERRACE LTD., holder of the Second Mortgage; andNEW BRUNSWICK HOUSING CORPORATION, holder of theThird Mortgage. Sale conducted under the terms of the Mortgage andthe Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freeholdproperty situate at 111 Inglewood Drive, in the Town of GrandBay-Westfield, in the County of Kings and Province of NewBrunswick. Notice of sale given by the above holder of the Mortgage.Sale at the Kings County Court House, 2-648 Main Street, Hampton,New Brunswick on Monday, the 15th day of December, A.D., 2003,at the hour of 10:30 o’clock in the forenoon, local time. See advertise-ment in the New Brunswick Telegraph-Journal in the issues ofNovember 13, 20, 27 and December 4, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC Mortgages Inc.

_________________

TROY PETER MCKINNEY and FIONA MCKINNEY, Owners of theEquity of Redemption and CIBC MORTGAGES INC., Mortgagee andholder of the Mortgage. Sale conducted under the terms of the Mort-gage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended.Freehold property situate at 161 Base Road, Willow Grove, in theCounty of Saint John and Province of New Brunswick. Notice of salegiven by the above holder of the Mortgage. Sale at the County CourtHouse, 22 Sydney Street, in the City of Saint John, in the County ofSaint John and Province of New Brunswick on Monday, the 15th dayof December, A.D., 2003, at the hour of 1:00 o’clock in the afternoon,

PETER DAVID WILSON et BARBARA ANN WILSON, propriétai-res du droit de rachat et débiteurs hypothécaires originaires; HYPO-THÈQUES CIBC INC., créancière hypothécaire et titulaire de l’hypo-thèque; DAVID GORDON WILSON, garant; et GREYSTONETERRACE LTD., titulaire de la deuxième hypothèque. Vente effec-tuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libresitués au 91, promenade Inglewood, ville de Grand Bay-Westfield,comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick. Avis de ventedonné par la susdite titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu lelundi 15 décembre 2003, à 10 h 15, heure locale, au palais de justice ducomté de Kings, 2-648, rue Main, Hampton (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 13, 20 et 27 novembre etdu 4 décembre 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la créancière hypothécaire, HypothèquesCIBC Inc.

__________________

KIMBERLY ANN BOWES, propriétaire du droit de rachat; et HYPO-THÈQUES CIBC INC., créancière hypothécaire et titulaire de l’hypo-thèque. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothè-que et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44.Biens en tenure libre situés au 26, avenue Meadow, ville de Hampton,comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick. Avis de ventedonné par la susdite titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu lelundi 15 décembre 2003, à 10 h, heure locale, au palais de justice ducomté de Kings, 2-648, rue Main, Hampton (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 13, 20 et 27 novembre etdu 4 décembre 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la créancière hypothécaire, HypothèquesCIBC Inc.

__________________

PETER DAVID WILSON et BARBARA ANN WILSON, propriétai-res du droit de rachat; HYPOTHÈQUES CIBC INC., créancière hypo-thécaire et titulaire de l’hypothèque; DAVID GORDON WILSON, ga-rant; GREYSTONE TERRACE LTD., titulaire de la deuxièmehypothèque; et LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK, titulaire de la troisième hypothèque. Vente effectuéeen vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loisur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre si-tués au 111, promenade Inglewood, ville de Grand Bay-Westfield,comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick. Avis de ventedonné par la susdite titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu lelundi 15 décembre 2003, à 10 h 30, heure locale, au palais de justice ducomté de Kings, 2-648, rue Main, Hampton (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 13, 20 et 27 novembre etdu 4 décembre 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la première créancière hypothécaire, Hypo-thèques CIBC Inc.

__________________

TROY PETER MCKINNEY et FIONA MCKINNEY, propriétairesdu droit de rachat; et HYPOTHÈQUES CIBC INC., créancière hypo-thécaire et titulaire de l’hypothèque. Vente effectuée en vertu des dis-positions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 161, che-min Base, Willow Grove, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titulaire de l’hypothè-que. La vente aura lieu le lundi 15 décembre 2003, à 13 h, heure locale,au palais de justice du comté, 22, rue Sydney, cité de Saint John, comtéde Saint John, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce pu-

Page 24: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1254 Gazette royale — 26 novembre 2003

local time. See advertisement in the New Brunswick Telegraph-Journalin the issues of November 13, 20, 27 and December 4, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC Mortgages Inc.

The Royal Gazette is published every Wednesday under the authorityof the Queen’s Printer Act. Documents must be received by TheRoyal Gazette editor, in the Queen’s Printer Office, no later thannoon, at least seven days prior to Wednesday’s publication. Eachdocument must be separate from the covering letter. Signatures ondocuments must be immediately followed by the printed name. TheQueen’s Printer may refuse to publish a document if any part of it isillegible, and may delay publication of any document for administra-tive reasons.Prepayment is required for the publication of all documents. Stan-dard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refunds will beissued for cancellations.

Annual subscriptions are $80.00 plus postage and expire December31st. If your subscription is not for a full calendar year, please contactthe Office of the Queen’s Printer to obtain a prorated amount.Single copies are $2.00. (Taxes are not included.)

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: (506) 453-2520 Fax: (506) 457-7899E-mail: [email protected]

NoticesCost perInsertion

Citation $ 20Examination for License as Embalmer $ 20Examination for Registration of Nursing Assistants $ 15Intention to Surrender Charter $ 15List of Names (cost per name) $ 10Notice under Board of Commissioners of Public Utilities $ 30Notice to Creditors $ 15Notice of Legislation $ 15Notice under Liquor Control Act $ 15Notice of Motion $ 20Notice under Political Process Financing Act $ 15Notice of Reinstatement $ 15Notice of Sale including Mortgage Sale and Sheriff Sale

Short Form $ 15Long Form (includes detailed property description) $ 60

Notice of Suspension $ 15Notice under Winding-up Act $ 15Order $ 20Order for Substituted Service $ 20Quieting of Titles — Public Notice (Form 70B)

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″ $ 75Writ of Summons $ 20Affidavits of Publication $ 5

Notice to Advertisers

bliée dans les éditions des 13, 20 et 27 novembre et du4 décembre 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la créancière hypothécaire, HypothèquesCIBC Inc.

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à laLoi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doiventparvenir à l’éditrice de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeurde la Reine, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publi-cation. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms dessignataires doivent suivre immédiatement la signature. L’Imprimeurde la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisibleet retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives.

Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voiciles tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit Mas-terCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l’ordre du minis-tre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en casd’annulation.Le tarif d’abonnement annuel est de 80 $, plus les frais postaux, etl’abonnement prend fin le 31 décembre. Si vous ne désirez pas unabonnement pour une année civile complète, veuillez communiqueravec le bureau de l’Imprimeur de la Reine afin d’obtenir un prixproportionnel. Le prix le numéro est de 2 $. (Taxes en sus)

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

Tél. : (506) 453-2520 Téléc. : (506) 457-7899Courriel : [email protected]

AvisCoût par parution

Citation 20 $Examen en vue d’obtenir un certificat d’embaumeur 20 $Examen d’inscription des infirmiers(ères) auxiliaires 15 $Avis d’intention d’abandonner sa charte 15 $Liste de noms (coût le nom) 10 $Avis – Commission des entreprises de service public 30 $Avis aux créanciers 15 $Avis de présentation d’un projet de loi 15 $Avis en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools 15 $Avis de motion 20 $Avis en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique 15 $Avis de réinstallation 15 $Avis de vente, y compris une vente de biens hypothéqués et

une vente par exécution forcéeFormule courte 15 $Formule longue (y compris la désignation) 60 $

Avis de suspension 15 $Avis en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies 15 $Ordonnance 20 $Ordonnance de signification substitutive 20 $Validation des titres de propriété (Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po 75 $Bref d’assignation 20 $Affidavits de publication 5 $

Avis aux annonceurs

Page 25: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1255 Gazette royale — 26 novembre 2003

NEW BRUNSWICKREGULATION 2003-82

under the

EMPLOYMENT STANDARDS ACT(O.C. 2003-353)

Filed November 7, 2003

Regulation Outline

Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Higher wage may be paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Maximum number of hours of work at a minimum wage . . . . . . . . . .4Minimum wage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Minimum wage for excess time worked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Boarding or lodging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Repeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Under section 9 of the Employment Standards Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation:

Citation

1 This regulation may be cited as the Minimum Wage Regulation -Employment Standards Act.

Application

2 This Regulation applies to every employee and employer inNew Brunswick.

Higher wage may be paid

3 The minimum wage fixed by this Regulation is a minimum wageonly, and a higher wage may be paid by an employer.

Maximum number of hours of work at minimum wage

4 The maximum number of hours of work for which the minimumwage fixed under section 5 shall be paid is 44 hours per week.

Minimum wage

5(1) Subject to subsection (3), the minimum wage is $6.20 per hour.

5(2) Wages paid to piece workers shall not be less that the minimumwage for the number of hours actually worked during a pay period.

5(3) The minimum wage for employees whose hours of work perweek are unverifiable and who are not strictly employed on a commis-sion basis is $272.80 per week.

Statutory Orders and Regulations Part II

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2003-82

établi en vertu de la

LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI(D.C. 2003-353)

Déposé le 7 novembre 2003

Sommaire

Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Salaire le plus élevé peut être versé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Nombre maximum d’heures de travail au salaire minimum . . . . . . . .4Salaire minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires . . . . . . . . .6Pension ou logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, lelieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :

Citation

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur lesalaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.

Application

2 Le présent règlement s’applique à tous les salariés et employeursdu Nouveau-Brunswick.

Salaire plus élevé peut être versé

3 Le salaire minimum fixé par le présent règlement n’est qu’un sa-laire minimum et n’empêche pas le paiement d’un salaire plus élevépar l’employeur.

Nombre maximum d’heures de travail au salaire minimum

4 Le nombre maximum d’heures de travail pour lequel le salaire mi-nimum fixé en vertu de l’article 5 est versé est de quarante-quatre heu-res par semaine.

Salaire minimum

5(1) Sous réserve du paragraphe (3), le salaire minimum est de 6,20 $l’heure.

5(2) Le salaire versé pour le travail à la pièce ne peut être inférieur ausalaire minimum pour le nombre d’heures effectivement travaillées aucours d’une période de paye.

5(3) Le salaire minimum des salariés dont le nombre d’heures de tra-vail par semaine ne peut être vérifié et qui ne sont pas strictement ré-munérés à la commission est de 272,80 $ par semaine.

Ordonnances statutaires et Règlements Partie II

Page 26: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387

The Royal Gazette — November 26, 2003 1256 Gazette royale — 26 novembre 2003

Minimum wage for excess time worked

6 The minimum wage payable for time worked in excess of the max-imum number of hours of work established under section 4 is $9.30 perhour.

Board or lodging

7 No amount shall be deducted from the minimum wage by an em-ployer for board or lodging which was not furnished by the employerto the employee.

Repeal

8 New Brunswick Regulation 2002-15 under the EmploymentStandards Act is repealed.

Commencement

9 This regulation comes into force on January 1, 2004.

Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires

6 Le salaire minimum devant être versé pour les heures de travail ensus du nombre maximum d’heures de travail fixé en vertu de l’article 4est de 9,30 $ l’heure.

Pension ou logement

7 L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pen-sion ou du logement qu’il n’a pas fourni au salarié.

Abrogation

8 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-15 établi en vertu dela Loi sur les normes d’emploi est abrogé.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés

Page 27: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387
Page 28: The Royal Gazette royale - New BrunswickThe Royal Gazette — November 26, 2003 1233 Gazette royale — 26 novembre 2003 513374 513374 N.B. LTD. 513385 513385 N.B. Ltd. 513387 513387