the royal gazette / gazette royale (09/11/11) · the royal gazette — november 11, 2009 1767...
TRANSCRIPT
The RoyalGazette
FrederictonNew Brunswick
Gazetteroyale
FrederictonNouveau-Brunswick
Vol. 167 Wednesday, November 11, 2009 / Le mercredi 11 novembre 2009 1765
ISSN 1714-9428
Notice to Readers
The Royal Gazette is officially published on-line.
Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator.
PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2009-435, I declare that An Act toAmend the Clean Water Act, Chapter 26 of the Acts of NewBrunswick, 2002, comes into force November 1, 2009.
This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on October15, 2009.
Michael Murphy, Q.C. Graydon NicholasAttorney General Lieutenant-Governor
________________
Proclamations
Avis aux lecteurs
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna-trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale.
PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2009-435, je déclare le1er novembre 2009 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiantla Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre 26 des Lois duNouveau-Brunswick de 2002.
La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 15 octobre 2009.
Le procureur général, Le lieutenant-gouverneur,Michael Murphy, c.r. Graydon Nicholas
________________
Proclamations
The Royal Gazette — November 11, 2009 1766 Gazette royale — 11 novembre 2009
PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2009-436, I declare that An Act toAmend the Clean Air Act, Chapter 27 of the Acts of NewBrunswick, 2002, comes into force November 1, 2009.
This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on October15, 2009.
Michael Murphy, Q.C. Graydon NicholasAttorney General Lieutenant-Governor
________________
PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2009-437, I declare that An Act toAmend the Pesticides Control Act, Chapter 28 of the Acts ofNew Brunswick, 2002, comes into force November 1, 2009.
This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on October15, 2009.
Michael Murphy, Q.C. Graydon NicholasAttorney General Lieutenant-Governor
OCTOBER 15, 20092009-433
Under section 27.1 of the Boiler and Pressure Vessel Act, theLieutenant-Governor in Council appoints or reappoints, as thecase may be, the following persons as members of the Board ofExaminers for Compressed Gas, for a term of three years, effec-tive October 15, 2009:
(a) appoints Michael Davidson, Rusagonis, NewBrunswick, designated as Chairman;(b) appoints David Evans, Saint John, New Brunswick;
(c) appoints Bruce Madsen, Rothesay, New Brunswick;
(d) appoints Chris Snow, Fredericton, New Brunswick; and
(e) reappoints Anthony Wilkins, Grand Bay-Westfield,New Brunswick.
Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor
________________
Orders in Council
PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2009-436, je déclare le1er novembre 2009 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiantla Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre 27 des Lois duNouveau-Brunswick de 2002.
La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 15 octobre 2009.
Le procureur général, Le lieutenant-gouverneur,Michael Murphy, c.r. Graydon Nicholas
________________
PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2009-437, je déclare le1er novembre 2009 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiantla Loi sur le contrôle des pesticides, chapitre 28 des Lois duNouveau-Brunswick de 2002.
La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 15 octobre 2009.
Le procureur général, Le lieutenant-gouverneur,Michael Murphy, c.r. Graydon Nicholas
LE 15 OCTOBRE 20092009-433
En vertu de l’article 27.1 de la Loi sur les chaudières et appa-reils à pression, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ounomme pour un nouveau mandat, selon le cas, les personnessuivantes membres du bureau des examinateurs en matière degaz comprimé, pour un mandat de trois ans, à compter du 15 oc-tobre 2009 :
a) nomme Michael Davidson, de Rusagonis (Nouveau-Brunswick), et le désigne président;b) nomme David Evans, de Saint John (Nouveau-Brunswick);c) nomme Bruce Madsen, de Rothesay (Nouveau-Brunswick);d) nomme Chris Snow, de Fredericton (Nouveau-Brunswick); ete) nomme pour un nouveau mandat Anthony Wilkins, deGrand Bay-Westfield (Nouveau-Brunswick).
Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas
________________
Décrets en conseil
The Royal Gazette — November 11, 2009 1767 Gazette royale — 11 novembre 2009
OCTOBER 15, 20092009-434
Under section 4 of the Boiler and Pressure Vessel Act, theLieutenant-Governor in Council appoints or reappoints, as thecase may be, the following persons as members of the Board ofExaminers for Power Engineers, for a term of three years, effec-tive October 15, 2009:
(a) appoints Eben Creaser, Fredericton, New Brunswick,designated as Chairman;(b) appoints Wayne Smart, Grand-Bay Westfield, NewBrunswick;(c) appoints George Lacey, Queenstown, New Brunswick;
(d) reappoints Kirby O’Donnell, Fredericton, NewBrunswick; and(e) reappoints Roch Fournier, St. Basile, New Brunswick.
Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor
________________
OCTOBER 15, 20092009-446
1. Under subsection 6(1) of the Elections Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints David Andrew Owens,Rusagonis, New Brunswick, as an Assistant Electoral Officerfor the Province of New Brunswick, effective October 15, 2009.
2. Under subsection 6(1) of the Elections Act and section 21 ofthe Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Council re-vokes Order in Council 2003-151 dated June 17, 2003.
Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor
________________
NOTICEOrders In Council issued during the month of
September 2009
September 2, 20092009-369 Appointments: Advocates under the Workers
Compensation Act2009-370 Appointments: Members and Alternate Mem-
bers of the Licensing Appeal Board2009-371 Regulation 93-104 - Fees Regulation - Vital Sta-
tistics Act amended
2009-372 Regulation 94-89 - Controlled Access Highwaysin Charlotte County Regulation - Highway Actamended
2009-373 Natural Resources Minister to exchange landswith Simwal Enterprises Ltd.
LE 15 OCTOBRE 20092009-434
En vertu de l’article 4 de la Loi sur les chaudières et appareilsà pression, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ounomme pour un nouveau mandat, selon le cas, les personnessuivantes membres du bureau des examinateurs des ingénieursspécialisés en force motrice, pour un mandat de trois ans, àcompter du 15 octobre 2009 :
a) nomme Eben Creaser, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), et le désigne président;b) nomme Wayne Smart, de Grand Bay-Westfield(Nouveau-Brunswick);c) nomme George Lacey, de Queenstown (Nouveau-Brunswick);d) nomme pour un nouveau mandat Kirby O’Donnell, deFredericton (Nouveau-Brunswick); ete) nomme pour un nouveau mandat Roch Fournier, deSaint-Basile (Nouveau-Brunswick).
Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas
________________
LE 15 OCTOBRE 20092009-446
1. En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi électorale, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme David AndrewOwens, de Rusagonis (Nouveau-Brunswick), directeur adjointdes élections pour la province du Nouveau-Brunswick, à comp-ter du 15 octobre 2009.2. En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi électorale et de l’arti-cle 21 de la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur enconseil révoque le décret en conseil 2003-151 pris le 17 juin2003.
Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas
________________
AVISDécrets en conseil pris durant le mois de
septembre 2009
Le 2 septembre 20092009-369 Nominations : défenseurs en vertu de la Loi sur
les accidents du travail2009-370 Nominations : membres et membres suppléants
du comité d’appel en matière de permis2009-371 Modification du Règlement 93-104, Règlement
sur les droits - Loi sur les statistiques de l’étatcivil
2009-372 Modification du Règlement 94-89, Règlementsur les routes à accès limité dans le comté deGloucester - Loi sur la voirie
2009-373 Ministre des Ressources naturelles autorisé àéchanger des biens-fonds avec Simwal Enterpri-ses Ltd.
The Royal Gazette — November 11, 2009 1768 Gazette royale — 11 novembre 2009
2009-385 Supply and Services Minister to convey propertylocated in the County of Gloucester to Glen,Pauline and Mona Ferguson
2009-386 Appointment: Deputy Superintendent of Insur-ance
2009-387 Appointments: Members of the Human RightsCommission
2009-388 Proclamation that the third session of the fifty-sixth Legislative Assembly be prorogued
2009-389 Proclamation that the Legislative Assembly ofthis Province be called to meet
September 9, 20092009-390 Reappointments: Members of the Board of
Directors of the Regional Health Authorities Aand B
2009-391 Appointment: Lay Person of the DisciplineCommittee of the Brunswick Association ofDieticians
2009-392 Reappointments: Members of the Mental HealthReview Boards
2009-393 Reappointments: Members of the NewBrunswick System Operator Board of Directors
September 17, 20092009-394 Appointment: Supplementary Member of the
New Brunswick Securities Commission
2009-395 Regulation 84-256 - General Regulation - Col-lection Agencies Act amended
2009-396 Regulation 2009-20 - General Regulation - Sea-food Processing Act amended
2009-397 Appointment: Member of the Mental HealthTribunal
2009-398 Debenture issue sold under ministerial borrow-ing authority
September 24, 20092009-404 Appointments: Members of the Premier’s Coun-
cil on the Status of Disabled Persons
2009-405 Appointments: Legislative Counsels2009-406 Appointments: Members of The Greater Shediac
Sewerage Commission2009-407 Appointments: Members of the New Brunswick
Health Council2009-408 Regulation 85-104 - General Regulation - Parks
Act amended2009-409 Regulation 84-250 - General Regulation - To-
bacco Tax Act2009-410 Proclamation of An Act to Amend the Crown
Lands and Forests Act, Chapter 23 of the Acts ofNew Brunswick, 2009
2009-411 Regulation 86-160 - Timber Regulation - CrownLands and Forests Act amended
2009-412 Proclamation of various sections of An Act toAmend the Mining Act, Chapter 35 of the Acts ofNew Brunswick, 2009
2009-413 Regulation 86-98 - General Regulation - MiningAct amended
2009-414 Expropriation of land located in the County ofCharlotte
2009-385 Ministre de l’Approvisionnement et des Servicesautorisé à céder à Glen, Pauline et MonaFerguson un bien situé dans le comté de Glou-cester
2009-386 Nomination : surintendant adjoint des assuran-ces
2009-387 Nominations : membres de la Commission desdroits de la personne du Nouveau-Brunswick
2009-388 Proclamation déclarant la clôture de la troisièmesession de la cinquante-sixième législature
2009-389 Proclamation convoquant l’Assemble législativede la province
Le 9 septembre 20092009-390 Renominations : membres des conseils d’admi-
nistration des régies régionales de la santé A et B
2009-391 Renomination : représentante non profession-nelle au comité de discipline de l’Associationdes diététistes du Nouveau-Brunswick
2009-392 Nominations : membres des commissions de re-cours de la santé mentale
2009-393 Renominations : membres du conseil d’adminis-tration de l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick
Le 17 septembre 20092009-394 Nomination : membre supplémentaire de la
Commission des valeurs mobilières duNouveau-Brunswick
2009-395 Modification du Règlement 84-256, Règlementgénéral - Loi sur les agences de recouvrement
2009-396 Modification du Règlement 2006-20, Règlementgénéral - Loi sur le traitement des poissons etfruits de mer
2009-397 Nomination : membre du tribunal de la santémentale
2009-398 Émission de débentures en vertu du pouvoird’emprunter du ministre
Le 24 septembre 20092009-404 Nominations : membres du Conseil du Premier
ministre sur la condition des personnes handica-pées
2009-405 Nominations : conseillers législatifs2009-406 Nominations : membres de la Commission des
égouts du Grand Shediac2009-407 Nominations : membres du Conseil du Nouveau-
Brunswick en matière de santé2009-408 Modification du Règlement 85-104, Règlement
général - Loi sur les parcs2009-409 Modification du Règlement 84-250, Règlement
général - Loi de la taxe sur le tabac2009-410 Proclamation de la Loi modifiant la Loi sur les
terres et forêts de la Couronne, chapitre 23 desLois du Nouveau-Brunswick de 2009
2009-411 Modification du Règlement 86-160, Règlementsur le bois - Loi sur les terres et forêts de la Cou-ronne
2009-412 Proclamation de divers articles de la Loi modi-fiant la Loi sur les mines, chapitre 35 des Lois duNouveau-Brunswick de 2009
2009-413 Modification du Règlement 86-98 intitulé Rè-glement général - Loi sur les mines
2009-414 Expropriation d’un bien-fonds dans le comté deCharlotte
The Royal Gazette — November 11, 2009 1769 Gazette royale — 11 novembre 2009
051384 051384 N.B. LTD.059300 059300 N.B. LTD.504078 504078 N.-B. INC.511146 511146 N.B. Ltd.511233 511233 N.B. Ltd.511262 511262 N.B. Ltd.604377 511543 NB LTD513943 513943 N.B. INC.605352 605352 N.B. LTD.605510 605510 N.B. INC.610995 610995 N. B. LTD.616870 616870 N.-B. Ltée617016 617016 N.B. LTD.617058 617058 N.B. Inc.617098 617098 New Brunswick Ltd. 617098
Nouveau-Brunswick Ltée630285 630285 NB Ltd. 630285 NB Ltée630396 630396 N.B. Ltd.630437 630437 (N.B.) Ltd.617327 A & D Security Ltd.630006 A.M.I. MUSICAL INSTRUMENTS
LTD.033201 ADMIRAL POOLS & SPA LTD.041308 ALL HIS RESTAURANTS LTD.000422 ALLABY FARMS LTD.630100 ARIA NIKAN CANADA LTD.630306 Big Bear & Buck Outfitters Ltd.630352 Blizzard Buildings Inc.623661 Bramdale Production Limited630467 BRUNSWICK CEDAR INC.506483 CANAM AIRSEAL LTD.508819 CANDYLAND WHOLESALERS LTD.038591 CARWICK COMPANY INC.041395 CASSE-CROUTE PAULIN LTEE629893 Central Investments (1987) Limited630304 CHERRY MOUNTAIN
CONTRACTING INC.516179 CHESCOM ELECTRONICS LTD.623928 Consilium Mundi Inc.004636 D E B MANAGEMENT CO. LTD.605258 D. F. TRUCKING INC.630032 DMC Financial Ltd.506524 DOUGLAS GRASS ARCHITECT LTD.630319 Dream Street SS Pictures Inc.617064 E.B. ENGINEERED PANELS &
CONTROLS INC.
630376 Eastern Canada Agricultural Investment Inc
513896 EDDY’S COVE BAIT LTD.005919 EPICERIE MALLET LTEE516170 GML COMMERCIAL LTD.617339 Green Oak Trading Ltd.007686 HAGERMAN’S MECHANICAL
CONTRACTORS LTD.630050 Harry Rowe Renovations Inc007983 HERON MINES LTD.623660 Hesperia Equipment Company Inc.610708 HG FINANCIAL SERVICES INC.630182 HMS MULTIGUIDE INC.605234 homesteadsforsale.com Inc.605522 Hudson Oddities Inc.617384 INTIERLOGIC INC.049243 ISBILL ELECTRIC LTD.043810 J.C.S. TRANSPORT LTEE059579 J.N. CYR TRANSPORT INC611192 JDNB CONTRACTING LTD008785 JENCAN LTD.059449 JOE MOKA CAFE INC.053692 JONATHAN ENTERPRISES INC.009006 KASPER & RICHTER PRECISION
INSTRUMENTS LTD.617248 KENT HOME NURSING INC.630004 Kidz Kastle Limited002130 L. BOUDREAU & FILS LTEE038897 LAPOINTE TRUCKING LTD.623583 Lee’s Brothers Ltd611077 LEMSKY ENTERPRISES LTD.610719 Lena Beene Inc.610823 Les ambulances de la péninsule
(Tracadie) Ltée630366 LES ENTREPRISES HÉBERT ET
SAVOIE LTÉE630382 Les Voyages Ré-Ber Travels Inc.513947 M.D. & C. Trailer Sales Inc.617378 MIND MAP INC.630151 MPS Construction Inc.610888 MULTI-RECYCLING LTD.012026 NETTOYEUR CHALEUR (1979) LTEE-
CHALEUR CLEANERS (1979) LTD.617107 P FOR U LTD.617018 PLACE 400 INC.514000 PROMAX ELECTRIC LTD.
033225 R. S. JEWELLERS LTD.630020 REFRIGERATION PROJECT
MANAGEMENT SERVICES INC.611017 Richland Homes Ltd.610911 RIVERSIDE COACH LINES INC.616997 S.G. ALLAIN & SONS ENTERPRISES
LTD. LES ENTREPRISES S.G. ALLAIN & FILS LTÉE
014502 SABRA LIMITED623657 Selangor Trading Limited630008 Setting Sun Consulting Limited623748 Signature Woodworking Inc.056592 SIX F HOLDINGS INC.514021 SPROUT-LESS VEGETATION
CONTROL SYSTEMS, INC.511243 Star Hunter Productions N.B. Ltd.617102 Steelbank Tubular Inc.630414 Stepstone Publishing & Consulting Ltd.053508 SUPERIOR INTERIORS LTD.511362 SWANEY ASSOCIATES LIMITED630168 TECH SHORE INFORMATION
TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD.041356 TIMART INVESTMENTS LTD.630290 TJ Grounds Works Ltd.630328 Torran Investments Ltd.617243 Ultimate Concrete (Fredericton) Inc.014872 VERNON SCOTT CONTRACTING
LTD.623659 Viatron Systems Limited030097 VICTORIA MANAGEMENT
SERVICES LTD./SERVICES DE GESTION VICTORIA LTEE
508854 WAVECREST HOLDINGS LTD.605395 Weaver Transport Ltd.630331 Wetrock Trade Ltd.514026 Witherell Group Inc.059544 WOODSTOCK HAIR ACADEMY
(1995) LTD.616910 Worldwide Property Portfolio Inc.616956 YOUR-WAY HOME IMPROVEMENTS
LTD.630284 ZZZBOX INC.
Avis de dissolution de corporations provinciales et d’annulationde l’enregistrement des corporations extraprovinciales
Avis de dissolution de corporations provincialesSachez que les corporations provinciales suivantes ont été dissoutes endate du 26 octobre 2009 en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi sur lescorporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du26 octobre 2009.
Loi sur les corporationscommerciales
Notice of dissolution of provincial corporations and cancella-tion of the registration of extra-provincial corporations
Notice of dissolution of provincial corporationsTake notice that the following provincial corporations have been dis-solved as of October 26, 2009, pursuant to paragraph 139(1)(c) of theBusiness Corporations Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices and/or documents re-quired by the Act. Certificates of Dissolution have been issued datedOctober 26, 2009.
Business Corporations Act
____________________________________________________
The Royal Gazette — November 11, 2009 1770 Gazette royale — 11 novembre 2009
019287 A.M. Look Lobster Company075299 ATLANTIC WAFFLES INC.071973 METTLER-TOLEDO INC.
077565 MMCC INSURANCE SOLUTIONS INC.
078086 NEXIENT LEARNING CANADA INC.
630040 OPPORTUNITY ACCESS INCORPORATED
623992 Projexco Inc.
629747 Association des Étudiants Congo-Kinshasa de l’Atlantique (AECKA) inc.
025698 CLUB SPORTIF DES RIVIÈRES ACADIENNES INC./ACADIAN RIVERS SPORTS CLUB INC.
004918 DERBY PARISH RECREATION COUNCIL INC.
025061 FONDATION GLAZIER INC.007164 GLASSVILLE SEED POTATO
PRODUCERS INC.
022560 HAMPTON LIONS CLUB INC.008503 INTERNATIONAL MARINE
MAMMAL ASSOCIATION INC.000857 L’ASSOCIATION DES PECHEURS
D’HUITRES DE LA BAIE DE CARAQUET INC.
605451 SEVENTH DAY ADVENTIST REFORME CHURCH INC.
624120 Shen Shin Aikikai Inc.630198 STUDENTS RUN WITH IT INC.
015851 SUSSEX JAYCEES INC.605591 The Greater Moncton Osteoporosis
Association Inc.024351 WEST ISLES CLEAN ENVIRONMENT
ASSOCIATION INC.
609758 Angels Breath Cottage609094 Jardin de l’amour/Love Garden609957 L. & L. Rioux Holdings Reg’d
609634 Paul Boyle Gas Bar610066 Power Contracting & Renovations
Notice of cancellationof registration of extra-provincial corporations
Take notice that the registrations of the following extra-provincial cor-porations have been cancelled as of October 26, 2009, pursuant toparagraph 201(1)(a) of the Business Corporations Act as the said cor-porations have been in default in sending to the Director fees, noticesand/or documents required by the Act:
Avis d’annulation del’enregistrement des corporations extraprovinciales
Sachez que l’enregistrement des corporations extraprovinciales sui-vantes a été annulé en date du 26 octobre 2009 en vertu de l’alinéa201(1)a) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesditescorporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits,avis et/ou documents requis par la Loi :
Avis de dissolution de compagnies provincialesSoyez avisé que les compagnies provinciales suivantes ont été dissou-tes en date du 26 octobre 2009 en vertu de l’alinéa 35(1)c) de la Loisur les compagnies, puisque lesdites compagnies ont fait défaut defaire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis parla Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 26 octobre2009.
Loi sur les compagnies
Notice of dissolution of provincial companiesTake notice that the following provincial companies have been dis-solved as of October 26, 2009, pursuant to paragraph 35(1)(c) of theCompanies Act, as the said companies have been in default in sendingto the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Cer-tificates of Dissolution have been issued dated October 26, 2009.
Companies Act
SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellationscommerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a annulé, le26 octobre 2009, en vertu de ladite loi, l’enregistrement des certificatsde sociétés en nom collectif indiqués à l’Annexe « A » ci-jointe et descertificats d’appellations commerciales des commerces indiqués àl’annexe « B » ci-jointe en raison du fait que ces firmes ou commercesont négligé de faire enregistrer des certificats de renouvellement con-formément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) deladite loi, selon le cas.
Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et
des appellations commerciales
TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act has cancelled, effective October 26,2009, the registration of the certificates of partnership of the firms setforth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of businessnames of the businesses set forth in Schedule “B” annexed hereto byreason of the fact the said firms and businesses have failed to registercertificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) orsubsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act.
Partnerships and BusinessNames Registration Act
Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif
____________________________________________________
The Royal Gazette — November 11, 2009 1771 Gazette royale — 11 novembre 2009
332564 “PIZZA KIT”609779 ADVANCED MASSAGE THERAPY610097 AIRTEK ENVIRONMENTALS610041 Andrea’s Hair Design609831 Appetite Restaurant610088 ARCHIBALD BED & BREAKFAST610069 ATCON ENGINEERED WOOD
PRODUCTS610047 ATCON I-JOISTS610071 ATCON LAMINATED VENEER
LUMBER610070 ATCON LVL610147 ATLANTIC STREETCAR
ORGANIZATION610044 AVIDE DESIGN BUILD609735 BERNARD LEBLANC LOGGING609792 BILLIARD ATTIC609996 Blue Ridge Forest Management Services610092 BRUNSWICK PROCESS SERVERS609781 BUREAU DE LA PROTECTION DES
DROITS LINGUISTIQUES OFFICE OF THE PROTECTION OF LINGUISTIC RIGHTS
609798 C C CYCLE HOUSE609951 Casse-Croûte Perron609765 Club chez Marie au 415609766 Club du Rocher Country609797 COASTAL INTERIORS & MORE /
COASTAL INTÉRIEURS & PLUS
609967 CODIAC DRYWALL SERVICE609863 Community Diversity Development
Consulting610045 CONCEPTION-CONSTRUCTION
AVIDE609764 Cottage at Raven Rock609882 DECOR 8 FINISHING TOUCHES609096 Duo Distributors609778 ENTREPRISES F. SAVOIE609819 Garry Brinson Consulting610017 GreatNorth Consulting Services609904 H & J AUTO610024 HELEN’S MUSIC609857 It’s Diversity Business609871 J-M Boudreau Repair Shop609789 Jaypea Graphic Design609825 JP - Web609881 JSE RENOVATIONS609892 KARMA GUY610015 Kule Management Services610026 L.A.W.S. LIVING AIR & WATER
SOLUTIONS609931 Lawn Organics609811 LE LOOK IDÉAL609835 McGraw Marketing607715 Melanson Cement Finishing609839 Moncton Medical Directory609817 MPLEX609818 MPLEX SOLUTIONS
609776 National Demolition610125 New Leaf Decorators609909 New-Denmark Heritage Village609783 PAUL’S VALUE FOOD609830 PERFORMANCE ADVANTAGE
GROUP609827 PICCOTT PRODUCTS610108 POLAR DIGITAL609058 POLLOCK NATIONALEASE609995 RED BANK CONFECTIONARY609807 René Guitar Design & Photo610018 RIVER VALLEY FIREWOOD
PRODUCTIONS609924 SECUR-SITE610081 SISTER-FRIENDS & GEMS609606 Soul Essentials609705 SPEEDWELL ENTERPRISES610035 Stepping Stones Counselling Services610016 Sterling Cinemas609775 Stonetec Tile Marble610140 Subliminal609859 TOYO EXPRESS610151 VinylCutz610060 Walrus & Carpenter Shellfish609803 Wing’s Café & Lounge609244 YuCompute
Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales
NEW BRUNSWICK IMMIGRANT INVESTOR FUND Fredericton 646839 2009 10 15(2009) LTD.
Dynamic Photo Art & Signs Inc. Fredericton 647192 2009 10 14
647207 N.B. INC. Dieppe 647207 2009 10 15
647210 N.B. LTD. Bathurst 647210 2009 10 15
647212 NB Inc. Fredericton 647212 2009 10 15
647216 N.B. LTD. Saint John 647216 2009 10 16
Maritime Road Recycling Inc. Grand-Sault / Grand Falls 647217 2009 10 16
HELENE BURKE HOLDING INC. Shediac River 647218 2009 10 16
PAULINE BOURGEOIS HOLDING INC. Shediac River 647219 2009 10 16
MONIQUE BABINEAU HOLDING INC. Shediac River 647220 2009 10 16
RONALD BASTARACHE HOLDING INC. Shediac River 647221 2009 10 16
The Old Cosmo Inc. Moncton 647222 2009 10 16
647223 N.B. INC. Cocagne 647223 2009 10 16
Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1772 Gazette royale — 11 novembre 2009
647231 N.B. Inc. Fredericton 647231 2009 10 16
647237 NB Ltd. Salisbury 647237 2009 10 19
647241 N.B. Ltd. Maugerville 647241 2009 10 19
Life Host Inc. Moncton 647242 2009 10 19
Bill Ewing Sales and Service Inc. Bains Corner 647243 2009 10 19
ANTHONY LeBLANC PHARMACY LTD. Dalhousie Junction 647247 2009 10 19
647248 N.B. Inc. Saint John 647248 2009 10 19
HAMILTON HOMESTYLE DAYCARE LTD. Saint John 647249 2009 10 19
Greymarkets Canada Inc. Moncton 647250 2009 10 19
647252 NB INC. Sainte-Anne-de-Madawaska 647252 2009 10 19
Ground Floor Realty & Investments Inc. Moncton 647253 2009 10 19
(LL) Logistic Lumpers Inc. Dieppe 647255 2009 10 20
Chapel Grove Holdings Ltd. Summerville 647258 2009 10 20
Vector Solutions Inc. Richibucto Road 647263 2009 10 20
647269 NB Inc. Moncton 647269 2009 10 20
647276 N.B. Ltd. Moncton 647276 2009 10 20
647277 NB LTD. Riverview 647277 2009 10 20
TDN INVESTISSEMENTS INC. Tide Head 647280 2009 10 20
Smart Choice Life Inc. Fredericton 647287 2009 10 21
647290 N.B. INC. Dieppe 647290 2009 10 21
PARACO HOUSE BUYERS INC. Grand-Sault / Grand Falls 647291 2009 10 21
NECOR ENTERPRISES INC. Moncton 647295 2009 10 21
BASCON DEVELOPMENTS INC. Fredericton 647297 2009 10 21
Madsen Logistics Ltd. Saint John 647299 2009 10 21
W. Hugh Murphy Professional Corporation Moncton 647300 2009 10 21
Nigel Summerhayes Aviation Solutions Inc. Quispamsis 647302 2009 10 21
DRE CARMINA BARONE CORPORATION DSL de Drummond / 647313 2009 10 22PROFESSIONNELLE LSD of Drummond
647317 N.B. INC. Fredericton 647317 2009 10 22
Brighter Smiles Inc. Saint John 647319 2009 10 22
647320 NB Ltd. Fredericton 647320 2009 10 22
KCSA HOLDING INC. Beresford 647322 2009 10 22
Waltmann Invest & Finance Ltd. Fredericton 647323 2009 10 22
Geoffrey Bell Auctions Ltd. Saint John 647325 2009 10 22
FAMILY DINNERS DAILY LTD. Quispamsis 647326 2009 10 22
_____________________________________________________
The Royal Gazette — November 11, 2009 1773 Gazette royale — 11 novembre 2009
GEORGE BASTARACHE HOLDINGS LTD. 001485 2009 10 16
BASTARACHE’S AUTO SALVAGE (1986) LTD. 035504 2009 10 16
PRES-DU-LAC LTEE/LTD. 044462 2009 10 20
604476 N.B. LTD. 604476 2009 10 16
617791 NB Inc. 617791 2009 10 20
Modaki Holdings Inc. 641175 2009 10 19
Chemgreen Innovation Inc. 645144 2009 10 16
NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales
In relation to a certificate of amendment issued on October 16, 2009 under the name of “Maple Class Inc.”, being corporation #640672, notice isgiven that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment correcting the number of the corporation to“640742” on the certificate and the name of the corporation to “640742 N.B. LTD.” on Form 3.
Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 16 octobre 2009 à « Maple Class Inc. », dont le numéro de corporation est 640672,le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé modifiant le numéro de corporation à « 640742 » sur le certificatet le nom de la corporation à « 640742 N.B. LTD. » sur la formule 3.
_____________________________________________________
055338 NB Inc. Saturn of Fredericton Ltd. 055338 2009 10 19
K1 Multi inc. 634106 NB Inc. 634106 2009 10 19
Maple Class Inc. 640672 N.B. Ltd. 640672 2009 10 16
Maple Class Inc. 640742 N.B. LTD. 640742 2009 10 16
Alternative Clean Energy Capital Inc. Carbon 2 Liquid Inc. 640901 2009 10 16
Generation Property Group Inc. / 644613 NB Inc. 644613 2009 10 16Groupe Immobilier Generation Inc.
NST Holdings Inc. 646257 N.B. INC. 646257 2009 10 16
SILIKAL CANADA LTD. 646951 N.B. LTD. 646951 2009 10 19
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :
DatePrevious name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1774 Gazette royale — 11 novembre 2009
JIMBAR WELDING LTD. Nasonworth 030468 2009 10 16
TRACADIE EXCAVATION INC./EXCAVATION TRACADIE INC. Rivière-à-la-Truite 045851 2009 10 20
514284 N.B. LTD. Fredericton 514284 2009 10 16
Intergrove Limited Saint John 619365 2009 10 16
_____________________________________________________
MARITIME BEAUTY SUPPLY CO. LTD. Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 010513 2009 07 24
DR. ARDAVAN MAHIM PROFESSIONAL Ontario 507480 2009 09 24CORPORATION
DR. SYLVIE LEVESQUE CORPORATION Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 509345 2008 12 04PROFESSIONNELLE INC.
Colestone Inc. Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 614876 2009 01 21
Hamilton Paper Box Company Limited Canada 618298 2009 01 30
DARO Flooring Constructions Inc. Canada 624916 2009 10 06
628198 NB LTD. Canada 628198 2009 07 31
_____________________________________________________
LES ENTREPRISES ALDORIA BOUDREAU LTEE 005805 2009 10 15
MARION BAINES CORPORATION 508124 2009 10 20
Edgemount Enterprises Inc. 509469 2009 10 16
HACO CANADA INC. 619927 2009 10 15
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :
DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1775 Gazette royale — 11 novembre 2009
N. BRIDGLAND ENTERPRISES INC. Ontario Frank P. Hamm 646647 2009 10 13Saint John
Provincial Capital Corp. Ontario Peter J. Adams 647161 2009 10 13Fredericton
DUKE ENERGY SERVICES Colombie-Britannique / SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647174 2009 10 14CANADA ULC British Columbia Saint John
SAM MORTGAGES LTD. Alberta SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647175 2009 10 14Saint John
JCB Entrepreneurs Généraux Inc. Canada René J. Basque 647184 2009 10 14Moncton
BFL Canada Insurance Services Inc. Colombie-Britannique / SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647196 2009 10 15British Columbia Saint John
Clarke Road Transport USA Inc. Michigan SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647197 2009 10 15Saint John
BFL Canada Consulting Services Inc. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647198 2009 10 15BFL Canada Services Conseils Inc. Saint John
Stone 2009-WCP Flow-Through GP Ontario John D. Laidlaw 647228 2009 10 16Inc. Saint John
Merit Travel Ventures Inc. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647285 2009 10 21Saint John
Belisle Solution Nutrition Inc. Québec / Quebec SMSS Corporate Services (NB) Inc. 647289 2009 10 21Moncton
_____________________________________________________
THE D&B COMPANIES OF THE D&B COMPANIES OF Steven Christie 647185 2009 10 14CANADA LTD. CANADA LTD. Fredericton
DOLLARAMA INC. DOLLARAMA INC. SMSS Corporate Services 647286 2009 10 21(NB) Inc.Saint John
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :
ReferenceNumber Date
Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :
ReferenceAgent and Address Number Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1776 Gazette royale — 11 novembre 2009
Boaz Lighthouse International Ministries Inc. Fredericton 647240 2009 10 16
_____________________________________________________
Friends of Mount Carleton Provincial Park Inc. 641483 2009 10 20
J. Ouellet Fish Market & Joel Ouellet Edmundston 643149 2009 10 19Dépanneur Enrg.
SAINT JOHN SPORT & N. BRIDGLAND Saint John 646648 2009 10 13SOCIAL CLUB ENTERPRISES INC.
FREDERICTON SPORT & N BRIDGLAND Saint John 646650 2009 10 13SOCIAL CLUB ENTERPRISES INC.
MONCTON SPORT & N. BRIDGLAND Saint John 646651 2009 10 13SOCIAL CLUB ENTERPRISES INC.
University of Fredericton UC Education Inc. Fredericton 646735 2009 10 13
John D. Simonson Construction John Darrell Simonson Première nation de 646772 2009 10 08Eel Ground First Nation
Société Culturelle de Rivière-Verte Percy Therrien Rivière-Verte 646953 2009 10 15Dorothy MorinGerard Ward
Purple Haze Salon Brandi Doucet Campbellton 647076 2009 10 20
Re/Max Residex Entreprises Residex Entreprises Inc. Grand Sault / Grand Falls 647115 2009 10 08
Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes ont été émises à :
ReferenceNumber Date
Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commercialesPartnerships and Business Names
Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1777 Gazette royale — 11 novembre 2009
VALLEY SANDS K & C HOLDINGS LTD. Quispamsis 647142 2009 10 14ENTERTAINMENT CENTER
A Ward Oyster Donald Swasson Neguac 647167 2009 10 13
BOOKER REALTY Abacus Realty Ltd. Fredericton 647171 2009 10 13
Montana Consulting Group / Montana H R Services Inc. Moncton 647181 2009 10 14Groupe Conseil Montana
Bottom Line Music Boyle Conoley Inc. Fredericton 647193 2009 10 14
Les Entreprises Rainbow Mr. Stéphane Ethier Grand-Barachois 647206 2009 10 15
Licensed Mechanic & Aaron Prosser Moncton 647208 2009 10 15Machinist AT Work
Fredericton Jewellers Gary Mossman Fredericton 647209 2009 10 15
Centre E&P Sénéchal Center Town of Grand Falls Grand-Sault / Grand Falls 647211 2009 10 15
Max-Em Construction Lee Curry Tracadie-Sheila 647213 2009 10 15
R.W. Morton Construction Richard Morton Killarney Road 647214 2009 10 15
Sarah’s Seconds Tina Byers Hampton 647215 2009 10 16
BREAK AWAY CAFE Pat MacMullin Sussex 647225 2009 10 16
Nick’s Bazaar Nick Landry Moncton 647227 2009 10 16
MY PRIMITIVE TRUNK Chantal Theriault Grand-Sault / Grand Falls 647232 2009 10 16
CATERING SOLUTIONS BY James Ross Fredericton 647233 2009 10 16THE HAPPY BAKER AND BREWBAKERS
Earth Threadz Patricia (Rish) McGlynn Sainte-Marie-de-Kent 647235 2009 10 16
The Perfect Day Miramichi Ginette Garrish Napan 647236 2009 10 17
Creative Juices Identity Cory Pacione Fredericton 647244 2009 10 19Graphic Design Interactive
M. Cyr Mecanic Plus Enr. Michel Cyr Edmundston 647245 2009 10 19
RH Schwartz Carpentry and Roger H. Schwartz Douglas 647246 2009 10 19Maintenance Services
Frenchie’s Value Video Ronald Stuart Saint John 647251 2009 10 19
Capital Systems Integration Kent Monteith Hanwell 647254 2009 10 19& Automation
Candles & Sticks Mary McNee Fredericton 647259 2009 10 20
BrenTax Brenda Avery Upperton 647278 2009 10 20
IMT Training Services Ian Tisdale Fredericton 647279 2009 10 21
Glamour Cakes Kathy Gallant Boudreau Ouest / West 647288 2009 10 21
SASSY NAILS BY LISA Lisa Uguay Quispamsis 647293 2009 10 21
Lovely Betty Consignment Tina Robinson Fredericton 647294 2009 10 21Boutique
Jewelz By Angie Angela D. Stillwell Fredericton 647296 2009 10 21
The Royal Gazette — November 11, 2009 1778 Gazette royale — 11 novembre 2009
La Garderie La Riviere Mrs. Annie Doucet Landry Office 647298 2009 10 21
Rachelle’s Used Books Rachel Leaman Riverview 647301 2009 10 21
Reclaim Frames Paul Maybee Fredericton 647303 2009 10 21
Crocon Building Renovations Dale Atwin Kingsclear 647304 2009 10 21
Dieppe Superior Nutrition Shawn Richard Dieppe 647306 2009 10 22Essentials
Nos Origines Mrs. Johanne Parent Shediac Bridge 647324 2009 10 22
_____________________________________________________
R. G. MEUBLE ENG’R Roland Gauvin Petite-Lamèque 301418 2009 10 19
AUTO MAGIK Denis Desjardins Grand-Sault / Grand Falls 311909 2009 10 16
DAVIDSON FUNERAL HOME DAVIDSON’S FUNERAL Miramichi 327154 2009 10 19SERVICE LTD.
SOUND EXPRESSIONS Christian Gay Utopia 334313 2009 10 16
THE SHAMPORIUM Ruth McLellan Fredericton 342299 2009 10 20
Five Star Professional Maid Service Patricia Roy Belledune 346463 2009 10 16
Scholtens Hanwell Scholten’s Hanwell Ltd. Hanwell 608317 2009 10 19
Scholtens Oromocto Scholten’s Oromocto Ltd. Oromocto 608318 2009 10 19
L’ACADIEMIE Pierre Chicoine Beresford 613674 2009 10 14Henri HacheyRoseline Roy
PATTISON OUTDOOR JIM PATTISON Saint John 614131 2009 10 16ADVERTISING INDUSTRIES LTD.
McBRIDE ELECTRIC J. Richard McBride Richmond Corner 614474 2009 10 15
DROST CONSTRUCTION Shawn Drost Lake George 614496 2009 10 15
Traduction & Consultations SMJ Paul-Émile Thériault Fredericton 614564 2009 10 15
SEA SIDE GRILL Gisèle Arsenault Richibucto 614565 2009 10 20
Antithesis Designs Deborah Wybou Fredericton 614623 2009 10 20
J’M DeGroot Service Station Mona DeGroot Dundee 614660 2009 10 17
WORLDSOURCE SECURITIES WORLDSOURCE Fredericton 614712 2009 10 20SECURITIES INC.VALEURS MOBILIÈRES WORLDSOURCE INC.
WORLDSOURCE FINANCIAL Worldsource Financial Fredericton 614729 2009 10 16MANAGEMENT Management Inc.
Gestion Financiere Worldsource Inc.
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1779 Gazette royale — 11 novembre 2009
Woodshed Sound Hans Guenther Martini Fredericton 614747 2009 10 21
Moxey’s Country Kitchen Eric Moxon Maugerville 614873 2009 10 20
IOS Financial Services GE VFS Canada Limited Saint John 615071 2009 10 21PartnershipGE VFS Canada Société en commandite
Addison Leasing Addison On Bay Ltd. Fredericton 615128 2009 10 13
GLOBAL ALUMINA Global Alumina Corporation Saint John 615190 2009 10 19
BAYVIEW TRUCKS & Bayview Trucks & Equipment Saint John 615216 2009 10 13EQUIPMENT Ltd.
EMMERSON POOLS EMMERSON SERVICE Rothesay 615252 2009 10 21CENTER LTD.
_____________________________________________________
Bathurst Bearings & Services Beresford 609323 2009 10 16
BOOKER REALTY FIRST CLASS Fredericton 626656 2009 10 13
REALSTAR ADVISORY Fredericton 640908 2009 10 22
Mayberries Primitive Decor Riverview 645494 2009 10 14
_____________________________________________________
UNLIMITED IDEAS FUND Jason Donelle Moncton 646838 2009 10 15RAISING / LEVÉE DE FONDS Guy LosierIDÉES SANS LIMITES Kimberly Donelle
Nadine Duchenes
IMPULSIONS restaurant Christian Sirois Bathurst 647160 2009 10 13Marielle D’Amours Sirois
Mayberries Primitive Decor Tim Barter Riverview 647182 2009 10 14Todd Stoyles
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :
Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — November 11, 2009 1780 Gazette royale — 11 novembre 2009
LOBSTER BAY EATERY Megan Ruth Burley Saint Andrews 344549 2009 10 13Jonathan Wainwright Dey
PRASHAD’S Convenience & Take-Out Jesmin H. Elavia Saint John 614228 2009 10 19Harvesh F. Elavia
AC Cargo Limited Partnership - Québec / Quebec AC Cargo General Saint John 623535 2009 10 19Société en commandite AC Partner Inc.Cargo
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :
Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour
Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :
Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date
Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour
File No.: B-M-43-09
IN THE COURT OF QUEEN’S BENCH OF NEW BRUNSWICKTRIAL DIVISIONJUDICIAL DISTRICT OF BATHURST
IN THE MATTER of the Quieting of Titles Act, R.S.N.B.1973, c. Q-4, as amended, and Rule 70 of the Rules of Courtof New Brunswick,
-and-IN THE MATTER of an application by ANSELMECHIASSON for a certificate of title in respect to a certainproperty situate in Petite-Rivière-de-l’Île, in the Parish ofShippagan, in the County of Gloucester and Province of NewBrunswick.
Quieting of Titles Act
No. de dossier : B-M-43-09
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICKDIVISION DE PREMIÈRE INSTANCECIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE BATHURST
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la validation des titres depropriété, L.R.N.-B. 1973, c.Q-4, telle que modifiée, ainsique la Règle 70 des Règles de procédures du Nouveau-Brunswick,-et-DANS L’AFFAIRE d’une requête déposée par ANSELMECHIASSON, en vue d’obtenir un certificat de titre relative-ment à certains biens-fonds situés à Petite-Rivière-de-l’Île,dans la paroisse de Shippagan, dans le comté de Gloucesteret la province du Nouveau-Brunswick.
Loi sur la validationdes titres de propriété
The Royal Gazette — November 11, 2009 1781 Gazette royale — 11 novembre 2009
AVIS AU PUBLIC EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA
VALIDATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ (FORMULE 70B)
À QUI DE DROIT :ANSELME CHIASSON, de Pointe-Canot, dans le comté deGloucester, présentera une requête à la Cour, située au 254, rueSt-Patrick à Bathurst, Nouveau-Brunswick, dans la salle « E »,le 7 décembre 2009, à 9 h 45 a.m. en vue d’obtenir un certificatattestant qu’il est le propriétaire des biens-fonds situés àPetite-Rivière-de-l’Île, dans la paroisse civile de Shippagan,dans le comté de Gloucester et la province du Nouveau-Brunswick, et dont une description complète figure à l’annexe« A » et une copie de plan tel que celui-ci apparaît au Registredes concessions de la Couronne de la province du Nouveau-Brunswick lequel est joint à l’Annexe « B ».Quiconque prétend posséder un droit sur lesdits biens-fonds ouune partie de ceux-ci est tenu de comparaître à l’audition de larequête aux lieu, date et heure indiqués, en personne ou par l’in-termédiaire d’un avocat du Nouveau-Brunswick chargé de lereprésenter.Quiconque a l’intention de comparaître à l’audition de la re-quête et désire présenter une preuve en sa faveur est tenu, auplus tard le 30 novembre 2009;
a) déposer au greffe de la circonscription judiciaire deBathurst, à l’adresse indiquée, un exposé de sa demandecontraire attesté par affidavit accompagné d’une copie detoute preuve littérale; et
b) d’en signifier copie à l’avocat du requérant, Me AlineMorin de l’étude légale ALINE MORIN C.P. INC,4011, route 113, Savoie-Landing NB E8S 3C3.
La demande de quiconque omet de déposer et de signifier unedemande contraire, sera jugée irrecevable et le titre du requérantdeviendra absolu, sous la seule réserve des exceptions et réser-ves prévues aux alinéas 18(1) de la Loi sur la validation des ti-tres de propriété ainsi que les exceptions mentionnées dansl’annexe « B » de l’avis de requête, s’il y a lieu.Les opposants sont avisés que :
a) dans la présente instance, ils ont le droit d’émettre des do-cuments et de présenter leur preuve en français, en anglaisou dans les deux langues;
b) le requérant à l’intention d’utiliser la langue française; et
c) l’opposant qui a besoin des services d’un interprète àl’audience doit en aviser le greffier au moment du dépôtd’une demande contraire.
CET AVIS est signé et scellé au nom de la Cour du Banc de laReine par Donald C. Arseneau, greffier de la Cour, à la ville deBathurst, au Nouveau-Brunswick, le 23 octobre 2009.
Maître Donald C. Arseneau, Greffier, Cour du Banc de la Reinedu Nouveau-Brunswick, Division de première instance,254, rue St-Patrick, Bathurst, Nouveau-Brunswick E2A 3Z9
PUBLIC NOTICEUNDER THE QUIETING OF TITLES ACT
(FORM 70B)
TO WHOM IT MAY CONCERN:ANSELME CHIASSON of Pointe-Canot, in the County ofGloucester, will make an application before the Court at 254St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick, in Courtroom “E”,on the 7th day of December, 2009, at 9:45 a.m., for a certificatethat he is the owner of land located at Petite-Rivière-de-l’Île, inthe Civil Parish of Shippagan, in the County of Gloucester andProvince of New Brunswick, the legal description of which isset out in Schedule “A” and the plan as it appears in the NewBrunswick Crown land grant registry is attached to Schedule“B”.
If any person claims an interest in such land, or any part thereof,he must appear at the hearing of the application at the place andtime stated, either in person or by a New Brunswick lawyer act-ing on his behalf.
Any person who intends to appear at the hearing of the applica-tion and wishes to present evidence to support his position must,no later than the 30th day of November, 2009,
(a) file a statement of adverse claim, verified by affidavit, to-gether with a copy of any documentary evidence, in the of-fice of the clerk of the Judicial District of Bathurst, at theaddress shown below; and
(b) serve a copy thereof on the applicant’s lawyer, AlineMorin of the law firm ALINE MORIN C.P. INC.,4011 Route 113, Savoie Landing, New BrunswickE8S 3C3.
The claim of any person who does not file and serve an adverseclaim will be barred and the title of the applicant will becomeabsolute, subject only to the exceptions and qualifications men-tioned in subsection 18(1) of the Quieting of Titles Act and theexceptions mentioned in Schedule “B” of the notice of applica-tion, if applicable.Adverse claimants are advised that:
(a) they are entitled to issue documents and present evidencein the proceeding in English or French or both;
(b) the applicant intends to proceed in the French language;and
(c) an adverse claimant who requires the services of an inter-preter at the hearing must so advise the clerk upon filingan adverse claim.
THIS NOTICE is signed and sealed for the Court of Queen’sBench by Donald C. Arseneau, Clerk of the Court at Bathurst,New Brunswick, on the 23rd day of October, 2009.
Donald C. Arseneau, Clerk, Court of Queen’s Bench of NewBrunswick, Trial Division, 254 St. Patrick Street, Bathurst, NewBrunswick E2A 3Z9
The Royal Gazette — November 11, 2009 1782 Gazette royale — 11 novembre 2009
SCHEDULE “A”
Lot #1 PID: 20482998ALL AND SINGULAR that certain piece, parcel or tract ofland and premises situate, lying and being at Petite-Rivière-de-l’Ile, in the Civil Parish of Shippagan, in the Countyof Gloucester and the Province of New Brunswick and beingmore particularly bounded and described as follows:BEGINNING at a post standing in the Southeast angle of LotLetter D, granted to Pierre Chiasson, Island River Settlement,Shippegan Island; THENCE from said place of beginning andrunning by the Magnet of the year 1941 North fourteen degreesEast along the East limit of said lot thirty-seven chains and fiftylinks to another post standing in the Southwest angle of Lot Let-ter Y, granted to John Chiasson; THENCE South seventy-sixdegrees East along the Southern limit of said lot and said limitof Lot Letter X, granted to Alexander Campbell, fifteen chainsto another post standing in the Northwest angle of Lot Letter F,granted to Peter J. Chiasson and others; THENCE South four-teen degrees West along the Western limit of the last mentionedlot, thirty-five chains to another post standing in the Southwestangle of said lot; AND THENCE North eight-five degrees andfifty minutes West fifteen chains and twenty-five links to theplace of beginning.
CONTAINING fifty-four acres, more or less, and distinguishedas Lot Letter E, Island River Settlement, Shippegan Island.
Lot #2 PID: 20055604ALL AND SINGULAR that certain piece, parcel or tract ofland and premises situate, lying and being at Petite-Rivière del’Ile, in the Parish of Shippagan, in the county of Gloucester, inprovince of New Brunswick, more particularly bounded and de-scribed as follows:BEGINNING at a post, standing at the South-East angle of LotLetter E purchased by Jarvie Chiasson on Shippagan Island,South of Little River; THENCE running by the magnet of theyear 1861, North Thirteen degrees and Thirty minutes East,Thirty-Five chains to another post; THENCE South Seventy-Six degrees and Thirty minutes East, Fifteen chains to anotherpost; THENCE South Thirteen degrees and Thirty minutesWest, Thirty-Two chains and Fifty links to another post, and;THENCE North Eighty-Six degrees and Thirty minutes West,Fifteen chains and Twenty-Five links to the place of beginning.
CONTAINING Fifty Acres, more or less and distinguished asLot Letter F on Shippagan Island, South of Little River.
ANNEXE « A »
Lot 1 NID : 20482998TOUTE la parcelle de terre, y compris ses bâtiments, située àPetite-Rivière-de-l’Île, paroisse civile de Shippagan, comté deGloucester, province du Nouveau-Brunswick, et plus précisé-ment délimitée et désignée comme suit :
PARTANT d’un piquet situé à l’angle sud-est du lot D, concédéà Pierre Chiasson, de l’établissement d’Island River, îleLamèque; DE LÀ, dudit point de départ et selon le relevé ma-gnétique de l’an 1941, en direction nord quatorze degrés est, lelong de la limite est dudit lot, sur une distance de trente-septchaînes et cinquante maillons jusqu’à un autre piquet situé àl’angle sud-ouest du lot Y, concédé à John Chiasson; DE LÀ, endirection sud soixante-seize degrés est, le long de la limite suddudit lot et de la limite sud du lot X, concédé à AlexanderCampbell, sur une distance de quinze chaînes jusqu’à un autrepiquet situé à l’angle nord-ouest du lot F, concédé à Peter J.Chiasson et autres; DE LÀ, en direction sud quatorze degrésouest, le long de la limite ouest du lot mentionné en dernier lieu,sur une distance de trente-cinq chaînes jusqu’à un autre piquetsitué à l’angle sud-ouest dudit lot; ET DE LÀ, en direction nordquatre-vingt-cinq degrés cinquante minutes ouest, sur une dis-tance de quinze chaînes et vingt-cinq maillons jusqu’au point dedépart.AYANT UNE SUPERFICIE approximative de cinquante-quatre acres et figurant comme le lot E, établissement d’IslandRiver, île Lamèque.
Lot 2 NID : 20055604TOUTE la parcelle de terre, y compris ses bâtiments, située àPetite-Rivière-de-l’Île, paroisse de Shippagan, comté de Glou-cester, province du Nouveau-Brunswick, et plus précisémentdélimitée et désignée comme suit :
PARTANT d’un piquet situé à l’angle sud-est du lot E, achetépar Jarvie Chiasson, sur l’île Lamèque, au sud de Petite-Rivière-de-l’Île; DE LÀ, selon le relevé magnétique de l’an1861, en direction nord treize degrés trente minutes est, sur unedistance de trente-cinq chaînes jusqu’à un autre piquet; DE LÀ,en direction sud soixante-seize degrés trente minutes est, surune distance de quinze chaînes jusqu’à un autre piquet; DE LÀ,en direction sud treize degrés trente minutes ouest, sur une dis-tance de trente-deux chaînes et cinquante maillons jusqu’à unautre piquet; ET DE LÀ, en direction nord quatre-vingt-six de-grés trente minutes ouest, sur une distance de quinze chaînes etvingt-cinq maillons jusqu’au point de départ.AYANT UNE SUPERFICIE approximative de cinquante acreset figurant comme le lot F sur l’île de Lamèque, au sud dePetite-Rivière-de-l’Île.
The Royal Gazette — November 11, 2009 1783 Gazette royale — 11 novembre 2009
SCHEDULE “B” ANNEXE « B »
The Royal Gazette — November 11, 2009 1784 Gazette royale — 11 novembre 2009
NOTICEPUBLIC SERVICE LABOUR
RELATIONS ACTOCCUPATIONAL GROUP AMENDMENTS
Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour RelationsAct, notice is hereby given of amendments to the followingOccupational Group.
Scientific and Professional Category, Part IGroup: Medicine and DentistryDefinition:The promotion of public and individual health; the prevention,diagnosis and treatment of disease, both medical and dental; thetreatment of disabilities and abnormal physical and mental con-ditions, the provision of advice.
DELETED CLASSIFICATIONS CODEMedical Officer Administrative Level I 6237 2 01Medical Officer Administrative Level II 6238 2 01Medical Officer Administrative Level IV 6240 2 01
RETITLED CLASSIFICATION CODEMedical Officer Administrative Level III
to Medical Officer Administrative 6239 2 01
NOTICE UNDER THE CRIMINAL CODE OF CANADADESIGNATION
QUALIFIED TECHNICIAN – BREATH SAMPLES
Under the authority of subsection 254(1) of the Criminal Codeof Canada, I HEREBY DESIGNATE AS “qualified technician”qualified to operate an approved instrument for purposes ofprosecutions under the Criminal Code of Canada, the followingpersons:
LOCATION NAME
RCMP “J” Division François PaquetRCMP “J” Division Réjean RichardRCMP “J” Division Laura ScharfRCMP “J” Division Jonathan GreerRCMP “J” Division René BlanchardRCMP “J” Division Mark BlakelyRCMP “J” Division Cindy DibbleeRCMP “J” Division Christopher MacKenzie-Plante
Office of HumanResources
Department ofPublic Safety
AVISLOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LES SERVICES PUBLICSMODIFICATIONS AU GROUPE PROFESSIONNEL
Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations detravail dans les services publics, avis est donné par les présentesque des modifications ont été apportées au groupe PROFES-SIONNEL suivant :
Catégorie scientifique et professionelle, Partie IGroupe : Médecine et art dentaireDéfinition :La promotion de la santé individuelle et de la santé publique; laprévention, le diagnostic et le traitement des maladies, qui relè-vent du domaine médical et du domaine dentaire; le traitementd’incapacités et de troubles physiques et mentaux, ainsi que laprestation de conseils.
CLASSIFICATIONS SUPPRIMÉES CODEMédecin administrateur niveau I 6237 2 01Médecin administrateur niveau II 6238 2 01Médecin administrateur niveau IV 6240 2 01
CLASSIFICATION REDÉSIGNÉES CODEMédecin administrateur niveau III à
Médecin administrateur 6239 2 01
AVIS EN VERTU DU CODE CRIMINEL DU CANADA DÉSIGNATION
TECHNICIEN QUALIFIÉ – ÉCHANTILLONS D’HALEINE
En vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel du Canada, JEDÉSIGNE PAR LES PRÉSENTES la personnes suivante« technicien qualifié » habilité à manipuler un alcootest ap-prouvé aux fins de poursuites engagées pour l’application duCode criminel du Canada :
ENDROIT NOM
GRC – Division « J » François PaquetGRC – Division « J » Réjean RichardGRC – Division « J » Laura ScharfGRC – Division « J » Jonathan GreerGRC – Division « J » René BlanchardGRC – Division « J » Mark BlakelyGRC – Division « J » Cindy DibbleeGRC – Division « J » Christopher MacKenzie-Plante
Bureau des ressourceshumaines
Ministère de laSécurité publique
The Royal Gazette — November 11, 2009 1785 Gazette royale — 11 novembre 2009
DATED in the City of Fredericton, this 21st day of October,2009
Hon. John W. ForanMinister of Public Safety and Solicitor GeneralProvince of New Brunswick
TO: RONALD JAMES HUBBARD and SHERRY LEEGORMAN, of 2460 Route 118 Highway, McKinleyville, NBE9E 2H5;AND TO: BEAUBEAR CREDIT UNION LIMITED, of 376Water Street, Miramichi, New Brunswick, E1V 3V4, JudgmentCreditor;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CON-CERN.Freehold premises situate, lying and being at 2460 Route 118Highway, McKinleyville, in the County of Northumberland andProvince of New Brunswick. Notice of Sale given by BeaubearCredit Union Limited, holder of first mortgage. Sale on the 11th
day of December, 2009, at 11:00 a.m., at or near the steps ofthe Court House, 673 King George Highway, Miramichi, NewBrunswick. See advertisement in the Miramichi Leader.DATED at Miramichi, New Brunswick, this 16th day of Octo-ber, 2009.
Harvey R. Urquhart, URQUHART & HAYES, Barristers &Solicitors, P.O. Box 501, Suite 201, Miramichi, NewBrunswick E1V 3M6, Tel.: 506-627-0091, Fax: 506-627-0096, Solicitors for the Mortgagee Beaubear CreditUnion Limited
________________
To: Charles Michael Bulcock, of 9 Clayton Street, in the City ofFredericton, in the County of York and Province of NewBrunswick and Corinne Janet Baldwin, of 9 Clayton Street, inthe City of Fredericton, in the County of York and Province ofNew Brunswick, Mortgagors;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 9 Clayton Street,in the City of Fredericton, in the County of York and Provinceof New Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.
RCMP “J” Division José BruneauRCMP “J” Division Lee MurrayRCMP “J” Division Janie LévesqueRCMP “J” Division Chris CampbellRCMP “J” Division Troy Keirstead
Notices of Sale
FAIT dans la cité de Fredericton le 21 Octobre 2009.
L’hon. John W. ForanMinistre de la Sécurité publiqueet solliciteur général du Nouveau-Brunswick
DESTINATAIRES : RONALD JAMES HUBBARD etSHERRY LEE GORMAN, du 2460, route 118,McKinleyville (Nouveau-Brunswick) E9E 2H5;BEAUBEAR CREDIT UNION LIMITED, du 376, rueWater, Miramichi (Nouveau-Brunswick) E1V 3V4, créancièresur jugement;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 2460, route 118, McKinleyville,comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick.Avis de vente donné par Beaubear Credit Union Limited, titu-laire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 11 décem-bre 2009, à 11 h, dans les marches du palais de justice, ou toutprès, 673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans le Miramichi Leader.FAIT à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, le 16 octobre2009.
Harvey R. Urquhart, du cabinet Urquhart & Hayes,C.P. 501, bureau 201, Miramichi (Nouveau-Brunswick)E1V 3M6, tél. : 506-627-0091; téléc. : 506-627-0096, avocatsde la créancière hypothécaire, Beaubear Credit UnionLimited
________________
Destinataires : Charles Michael Bulcock, du 9, rue Clayton,ville de Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et Corinne Janet Baldwin, du 9, rue Clayton, villede Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 9, rue Clayton, ville deFredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.
GRC – Division « J » José BruneauGRC – Division « J » Lee MurrayGRC – Division « J » Janie LévesqueGRC – Division « J » Chris CampbellGRC – Division « J » Troy Keirstead
Avis de vente
The Royal Gazette — November 11, 2009 1786 Gazette royale — 11 novembre 2009
Sale on the 27th day of November, 2009, at 11:00 a.m., at theCourt House in Fredericton, 427 Queen Street, Fredericton,New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postponeor reschedule the time and date of sale. See advertisement inThe Daily Gleaner.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada
________________
To: Jason Scott Black, of 11 Lenwood Street, Lower Coverdale,in the County of Albert and Province of New Brunswick, Mort-gagor;And to: Citifinancial Canada East Corporation, 300 MainStreet, Suite F-1, Moncton, New Brunswick, E1C 1B9, 2nd
Mortgagee;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 11 LenwoodStreet, Lower Coverdale, in the County of Albert and Provinceof New Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 30th day of November, 2009, at 11:00 a.m., in thelobby of the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton,New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postponeor reschedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada
The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:
NoticesCost perInsertion
Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill
$ 20
Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission
$ 20
Notice to Advertisers
La vente aura lieu le 27 novembre 2009, à 11 h, au palais de jus-tice de Fredericton, 427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans The Daily Gleaner.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada
________________
Destinataires : Jason Scott Black, du 11, rue Lenwood, LowerCoverdale, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick,débiteur hypothécaire;CitiFinancière, corporation du Canada Est, 300, rue Main, bu-reau F-1, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1B9, 2e créan-cière hypothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 11, rue Lenwood, LowerCoverdale, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 30 novembre 2009, à 11 h, dans le foyer del’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :
AvisCoût par parution
Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé
20 $
Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau
20 $
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette — November 11, 2009 1787 Gazette royale — 11 novembre 2009
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.
The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.
Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117
P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1
Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]
Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct
$ 25
Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act
$ 20
Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″
$120
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less
$ 20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length
$ 75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)
$ 20
Notice of a correction charge isthe same as
for publishing the original document
Any other document $3.50 for each cm or less
Statutory Orders and Regulations Part II
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.
La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.
Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117
C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899
Courriel : [email protected]
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés
25 $
Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le
financement de l’activité politique20 $
Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions
20 $
Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po
120 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur
20 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur
75 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)
20 $
Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés
pour la publication du
document original
Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou
moins
Ordonnances statutaires et Règlements Partie II
The Royal Gazette — November 11, 2009 1788 Gazette royale — 11 novembre 2009
NEW BRUNSWICKREGULATION 2009-121
under the
RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2009-121
pris en vertu de la
CROWN CONSTRUCTION CONTRACTS ACT(O.C. 2009-448)
LOI SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTIONDE LA COURONNE
(D.C. 2009-448)
Filed October 28, 2009 Déposé le 28 octobre 2009
1 Section 6 of New Brunswick Regulation 82-109 un-der the Crown Construction Contracts Act is amended
1 L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de cons-truction de la Couronne est modifié
(a) in subsection (2) a) au paragraphe (2),
(i) in paragraph (a) by striking out “Board ofSchool Trustees” wherever it appears and substi-tuting “District Education Council”;
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « conseilscolaire » chaque fois qu’il s’y trouve et son rem-placement par « conseil d’éducation de district »;
(ii) in paragraph (b) by striking out “Board ofSchool Trustees” wherever it appears and substi-tuting “District Education Council”;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « conseilscolaire » et son remplacement par « conseil d’édu-cation de district »;
(b) in subsection (3) in the portion preceding para-graph (a) by striking out “Board of School Trustees”and substituting “District Education Council”;
b) au paragraphe (3) au passage qui précède l’ali-néa a), par la suppression de « conseil scolaire » et sonremplacement par « conseil d’éducation de district »;
(c) in subsection (4) by striking out “Board ofSchool Trustees” and substituting “District EducationCouncil”;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « conseilscolaire » et son remplacement par « conseil d’éduca-tion de district »;
(d) in paragraph (5)(a) by striking out “Board ofSchool Trustees” wherever it appears and substituting“District Education Council”;
d) à l’alinéa (5)a), par la suppression de « conseilscolaire » chaque fois qu’il s’y trouve et son rempla-cement par « conseil d’éducation de district »;
(e) in subsection (6) by striking out “Board ofSchool Trustees” wherever it appears and substituting“District Education Council”.
e) au paragraphe (6), par la suppression de « conseilscolaire » et son remplacement par « conseil d’éduca-tion de district ».
The Royal Gazette — November 11, 2009 1789 Gazette royale — 11 novembre 2009
2 Paragraph 7(1)(a) of the Regulation is repealed andthe following is substituted:
2 L’alinéa 7(1)a) du Règlement est abrogé et remplacépar ce qui suit :
(a) reasonably in advance of the tender closing date,public advertisement of the work to be carried out;
a) la publication, dans un délai raisonnable avant ladate limite de réception des offres, d’annonces publi-ques des travaux à exécuter;
COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR
3 This Regulation comes into force on April 1, 2010. 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril2010.
The Royal Gazette — November 11, 2009 1790 Gazette royale — 11 novembre 2009
NEW BRUNSWICKREGULATION 2009-122
under the
RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2009-122
pris en vertu de la
FISH AND WILDLIFE ACT(O.C. 2009-449)
LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE(D.C. 2009-449)
Filed October 28, 2009 Déposé le 28 octobre 2009
1 Schedule A of New Brunswick Regulation 84-124under the Fish and Wildlife Act is repealed and the at-tached Schedule A is substituted.
1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la fauneest abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
The Royal Gazette — November 11, 2009 1791 Gazette royale — 11 novembre 2009
SCHEDULE A ANNEXE A
SPECIES ANDCONDITIONS OF
USE
KILLING TRAPS
BEAVER Bélisle Classic 330Bélisle Super X 280Bélisle Super X 330BMI 280BMI 330Bridger 330Duke 330LDL C280LDL C280 MagnumLDL C330LDL C330 MagnumRudy 280Rudy 330Sauvageau 1000-11FSauvageau 2001-8Sauvageau 2001-11Sauvageau 2001-12Species-Specific 330 Dislocator Half-MagnumSpecies-Specific 440 Dislocator Half-MagnumWoodstream Oneida Victor 280Woodstream Oneida Victor 330
FISHER Bélisle Super X 120Bélisle Super X 160Bélisle Super X 220Koro #2LDL C160 MagnumLDL C220 MagnumRudy 120 MagnumRudy 160 PlusRudy 220 PlusSauvageau 2001-5Sauvageau 2001-6Sauvageau 2001-7Sauvageau 2001-8
MARTEN Bélisle Super X 120Bélisle Super X 160BMI 126 MagnumKoro #1LDL B120 MagnumNorthwoods 155Rudy 120 MagnumRudy 160 PlusSauvageau C120 MagnumSauvageau 2001-5Sauvageau 2001-6
ESPÈCES ETCONDITIONS
D’UTILISATION
PIÈGES MORTELS
CASTOR Bélisle Classic 330Bélisle Super X 280Bélisle Super X 330BMI 280BMI 330Bridger 330Duke 330LDL C280LDL C280 MagnumLDL C330LDL C330 MagnumRudy 280Rudy 330Sauvageau 1000-11FSauvageau 2001-8Sauvageau 2001-11Sauvageau 2001-12Species-Specific 330 Dislocator Half-MagnumSpecies-Specific 440 Dislocator Half-MagnumWoodstream Oneida Victor 280Woodstream Oneida Victor 330
PÉKAN Bélisle Super X 120Bélisle Super X 160Bélisle Super X 220Koro #2LDL C160 MagnumLDL C220 MagnumRudy 120 MagnumRudy 160 PlusRudy 220 PlusSauvageau 2001-5Sauvageau 2001-6Sauvageau 2001-7Sauvageau 2001-8
MARTRE Bélisle Super X 120Bélisle Super X 160BMI 126 MagnumKoro #1LDL B120 MagnumNorthwoods 155Rudy 120 MagnumRudy 160 PlusSauvageau C120 MagnumSauvageau 2001-5Sauvageau 2001-6
The Royal Gazette — November 11, 2009 1792 Gazette royale — 11 novembre 2009
MUSKRATLand only
Bélisle Super X 120BMI 120BMI 120 MagnumBMI 126 MagnumBridger 120Duke 120Koro MuskratLDL B120 MagnumOuell 411-180Rudy 110Rudy 120Rudy 120 MagnumSauvageau C120 MagnumSauvageau 2001-5Sauvageau C120 “Reverse Bend”Triple MWoodstream Oneida Victor 110Woodstream Oneida Victor 120
MUSKRATUnderwater only
Any jaw type trap (body gripping or leghold) set as a submersion set that exerts aclamping force on a muskrat and thatmaintains a muskrat underwater
RACOON Bélisle Classic 220Bélisle Super X 160Bélisle Super X 220Bélisle Super X 280BMI 160BMI 220BMI 280BMI 280 MagnumBridger 160Bridger 220Duke 160Duke 220LDL C160LDL C220LDL C220 MagnumLDL C280 MagnumNorthwoods 155Rudy 160Rudy 160 PlusRudy 220Rudy 220 PlusSauvageau 2001-6Sauvageau 2001-7Sauvageau 2001-8Species-Specific 220 Dislocator Half-MagnumWoodstream Oneida Victor 160Woodstream Oneida Victor 220
RAT MUSQUÉSur la terre ferme
seulement
Bélisle Super X 120BMI 120BMI 120 MagnumBMI 126 MagnumBridger 120Duke 120Koro MuskratLDL B120 MagnumOuell 411-180Rudy 110Rudy 120Rudy 120 MagnumSauvageau C120 MagnumSauvageau 2001-5Sauvageau C120 “Reverse Bend”Triple MWoodstream Oneida Victor 110Woodstream Oneida Victor 120
RAT MUSQUÉSous l’eau seulement
Tout type de piège à mâchoires (mortel ou àpalette) qui exerce sur un rat musqué uneforce de serrage et qui le maintient sousl’eau
RATON LAVEUR Bélisle Classic 220Bélisle Super X 160Bélisle Super X 220Bélisle Super X 280BMI 160BMI 220BMI 280BMI 280 MagnumBridger 160Bridger 220Duke 160Duke 220LDL C160LDL C220LDL C220 MagnumLDL C280 MagnumNorthwoods 155Rudy 160Rudy 160 PlusRudy 220Rudy 220 PlusSauvageau 2001-6Sauvageau 2001-7Sauvageau 2001-8Species-Specific 220 Dislocator Half-MagnumWoodstream Oneida Victor 160Woodstream Oneida Victor 220
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved/Tous droits réservés